SENSOR HIGHWAY LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | SENSOR HIGHWAY LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 03148432 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SENSOR HIGHWAY LIMITED?
- Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural (09100) / Exploração de minas e pedreiras
Onde fica SENSOR HIGHWAY LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Minerva Manor Royal RH10 9BU Crawley United Kingdom |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de SENSOR HIGHWAY LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2021 |
Quais são as últimas submissões para SENSOR HIGHWAY LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despacho judicial Scheme of amalgamation | 8 páginas | OC | ||||||||||||||
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Despacho judicial Diss by c/order | 1 páginas | OC | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2021 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/01/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Christopher Allan Walker como diretor em 18/08/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Giselle Evette Varn como diretor em 04/08/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Gary Park como diretor em 31/07/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Alteração dos detalhes de Schlumberger Oilfield Uk Plc como pessoa com controlo significativo em 15/07/2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Schlumberger House Buckingham Gate Gatwick Airport West Sussex RH6 0NZ para Minerva Manor Royal Crawley RH10 9BU em 15/07/2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Alteração dos detalhes de uma pessoa com controlo significativo | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/01/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nomeação de Colin David Beddall como diretor em 06/12/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2020 | 16 páginas | AA | ||||||||||||||
Término da nomeação de Mark Roman Higgins como secretário em 30/07/2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Mark Roman Higgins como diretor em 30/07/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Estado do capital em 02/06/2021
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mrs Giselle Evette Varn em 15/03/2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mrs Giselle Evette Varn como diretor em 18/01/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/01/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2019 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Quem são os diretores de SENSOR HIGHWAY LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDDALL, Colin David, Mr. | Diretor | Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London 29 United Kingdom | United Kingdom | British | Risk & Insurance Manager | 287316070001 | ||||
WALKER, Christopher Allan | Diretor | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | Finance Manager | 299227560001 | ||||
BURY, Christopher John | Secretário | The Haywain Church Lane HP27 9AW Princes Risborough Buckinghamshire | British | Finance Dir | 50759420001 | |||||
DROY MOORE, Pauline | Secretário | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | British | 138236320002 | ||||||
GAMBLE, Geoffrey Robert | Secretário | 14 Fair View SO24 9PR Alresford Hampshire | British | 13438090001 | ||||||
HIGGINS, Mark Roman | Secretário | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | 270622470001 | |||||||
RAY, Neil | Secretário | Grafton OX18 2RY Bampton Poplar Barn Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 32255250004 | |||||
SMOKER, Simon | Secretário | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203968040001 | |||||||
BOUMBA, Christel Kevin Geraud | Diretor | Lavender Hill Flat 1 SW11 5QJ London 151 | Congolese | Accountant | 140163890001 | |||||
BURY, Christopher John | Diretor | The Haywain Church Lane HP27 9AW Princes Risborough Buckinghamshire | British | Finance Dir | 50759420001 | |||||
DAWNAY, John Christian George, Rt Hon Viscount Downe | Diretor | Wykeham Abbey YO13 9QS Scarborough North Yorkshire | British | Director | 9157410001 | |||||
DROY MOORE, Pauline | Diretor | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 138236320003 | ||||
GOLDBY, Alan John | Diretor | 33 Tyne Crescent Brickhill MK41 7UJ Bedford Bedfordshire | British | Accountant | 7619430001 | |||||
HIGGINS, Mark Roman | Diretor | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | England | British | Senior Tax Manager | 256940520001 | ||||
JAIME, Cesar | Diretor | Flat 18 10 Horseshoe Bridge Quay 2000 SO17 2NP Southampton Hampshire | Colombian | Managing Director | 92523390001 | |||||
KALB, Frederique | Diretor | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | French | Product Development Manager | 172326000001 | ||||
KLUTH, Erhard Lothar Edgar, Dr | Diretor | The Town Mill Mill Lane SO24 9DD Alresford Hampshire | Canadian | Director | 12845860001 | |||||
LE FLOCH, Gilles | Diretor | Rue Des Bigauds 78750 Mareil-Marly 120 France | French | Product Development Manager | 140343550001 | |||||
LEGGETT, Nigel | Diretor | Barnfell House Landford SP5 2QP Salisbury | British | Technical Director | 116531940001 | |||||
MARSH, David | Diretor | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 171331520001 | ||||
MARTIN, Rebecca Helen | Diretor | Mount Ash Road SE26 6LY London 28 | United Kingdom | New Zealander | Acc | 134158470001 | ||||
MCCANN, Dominic Patrick Joseph | Diretor | The Dolls House Toothill SO51 9LN Romsey Hampshire | England | Irish | General Manager | 123011020001 | ||||
PARK, Gary | Diretor | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 270424580001 | ||||
PIESSE, Alan Roger | Diretor | 3 Russet Glade Cranmore Lane GU11 3BF Aldershot Hampshire | British | Sales & Marketing Director | 44675130001 | |||||
PLATT, John Camm | Diretor | Meadows Martyr Worthy SO21 1DZ Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Non-Executive Chairman | 8496300002 | ||||
RAY, Neil | Diretor | Grafton OX18 2RY Bampton Poplar Barn Oxfordshire | England | British | Chartered Accountant | 32255250004 | ||||
REYNOLDS, John Thomas | Diretor | 90 Reeters Ridge Road IRISH Westport 06897 Connecticut Usa | American | Venture Capitalist | 69090740001 | |||||
RIST, Samantha Martha | Diretor | School Road Bursledon SO31 8BY Southampton Advent Cottage Hampshire United Kingdom | American | Manager | 138420520001 | |||||
ROBERSON, Iain Malcolm | Diretor | Merry Hills Cottage Merry Hills Lane Loxwood RH14 0RB Billingshurst West Sussex | British | Director | 73503750001 | |||||
SMOKER, Simon | Diretor | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | England | British | Accountant | 134158640002 | ||||
TERTYCHNY, Vladimir, Dr | Diretor | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | United Kingdom | Russian | Center Manager | 193152670001 | ||||
VARN, Giselle Evette | Diretor | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | Eur Controller | 273564740002 | ||||
WHITE, Simon Meredith | Diretor | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | England | British | Financial Controller | 130781300001 | ||||
WILLIAMS, Glynn Richard | Diretor | The Old Post Office Easton SO21 1EF Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Managing Director | 36481970003 | ||||
YOUNG, Michael John | Diretor | Blairs Culterhouse Road Milltimber AB13 0EZ Aberdeen Scotland | British | Non-Executive Director | 38513840001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SENSOR HIGHWAY LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlumberger Oilfield Uk Plc | 06/04/2016 | Manor Royal RH10 9BU Crawley Minerva United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
SENSOR HIGHWAY LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Criado em 04/03/2002 Entregue em 15/03/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição £6,547.25. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Rent deposit deed | Criado em 29/09/2000 Entregue em 12/10/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date (as defined therein) | |
Breve descrição The sum of £6161.19, an interest bearing account, the amount standing to the credit of the deposit account, all interest credited from time to time. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Rent deposit deed | Criado em 27/01/1998 Entregue em 28/01/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 26TH september 1997 | |
Breve descrição £4,387.50 plus vat and the amount from time to time standing to the credit of the deposit account and all interest credited to the deposit account from to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 23/08/1996 Entregue em 29/08/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0