SENSOR HIGHWAY LIMITED

SENSOR HIGHWAY LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSENSOR HIGHWAY LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03148432
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SENSOR HIGHWAY LIMITED?

    • Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural (09100) / Exploração de minas e pedreiras

    Onde fica SENSOR HIGHWAY LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Minerva
    Manor Royal
    RH10 9BU Crawley
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de SENSOR HIGHWAY LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2021

    Quais são as últimas submissões para SENSOR HIGHWAY LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Despacho judicial

    Scheme of amalgamation
    8 páginasOC

    Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória

    Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued
    1 páginasGAZ2

    Despacho judicial

    Diss by c/order
    1 páginasOC

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Directors actions authorised in relation to the scheme 02/11/2023
    RES13

    Contas anuais preparadas até 31/12/2021

    15 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 19/01/2023 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr Christopher Allan Walker como diretor em 18/08/2022

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Giselle Evette Varn como diretor em 04/08/2022

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Gary Park como diretor em 31/07/2022

    1 páginasTM01

    Alteração dos detalhes de Schlumberger Oilfield Uk Plc como pessoa com controlo significativo em 15/07/2022

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de Schlumberger House Buckingham Gate Gatwick Airport West Sussex RH6 0NZ para Minerva Manor Royal Crawley RH10 9BU em 15/07/2022

    1 páginasAD01

    Alteração dos detalhes de uma pessoa com controlo significativo

    2 páginasPSC05

    Declaração de confirmação apresentada em 19/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Colin David Beddall como diretor em 06/12/2021

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2020

    16 páginasAA

    Término da nomeação de Mark Roman Higgins como secretário em 30/07/2021

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Mark Roman Higgins como diretor em 30/07/2021

    1 páginasTM01

    Estado do capital em 02/06/2021

    • Capital: GBP 18,000
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 23/04/2021
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Detalhes do diretor alterados para Mrs Giselle Evette Varn em 15/03/2021

    2 páginasCH01

    Nomeação de Mrs Giselle Evette Varn como diretor em 18/01/2021

    2 páginasAP01

    Declaração de confirmação apresentada em 19/01/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2019

    15 páginasAA

    Quem são os diretores de SENSOR HIGHWAY LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BEDDALL, Colin David, Mr.
    Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    29
    United Kingdom
    Diretor
    Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    29
    United Kingdom
    United KingdomBritishRisk & Insurance Manager287316070001
    WALKER, Christopher Allan
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    ScotlandAmericanFinance Manager 299227560001
    BURY, Christopher John
    The Haywain Church Lane
    HP27 9AW Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secretário
    The Haywain Church Lane
    HP27 9AW Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishFinance Dir50759420001
    DROY MOORE, Pauline
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secretário
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    British138236320002
    GAMBLE, Geoffrey Robert
    14 Fair View
    SO24 9PR Alresford
    Hampshire
    Secretário
    14 Fair View
    SO24 9PR Alresford
    Hampshire
    British13438090001
    HIGGINS, Mark Roman
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    Secretário
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    270622470001
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Secretário
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant32255250004
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secretário
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    203968040001
    BOUMBA, Christel Kevin Geraud
    Lavender Hill
    Flat 1
    SW11 5QJ London
    151
    Diretor
    Lavender Hill
    Flat 1
    SW11 5QJ London
    151
    CongoleseAccountant140163890001
    BURY, Christopher John
    The Haywain Church Lane
    HP27 9AW Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Haywain Church Lane
    HP27 9AW Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishFinance Dir50759420001
    DAWNAY, John Christian George, Rt Hon Viscount Downe
    Wykeham Abbey
    YO13 9QS Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Wykeham Abbey
    YO13 9QS Scarborough
    North Yorkshire
    BritishDirector9157410001
    DROY MOORE, Pauline
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary138236320003
    GOLDBY, Alan John
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    BritishAccountant7619430001
    HIGGINS, Mark Roman
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritishSenior Tax Manager256940520001
    JAIME, Cesar
    Flat 18 10 Horseshoe Bridge
    Quay 2000
    SO17 2NP Southampton
    Hampshire
    Diretor
    Flat 18 10 Horseshoe Bridge
    Quay 2000
    SO17 2NP Southampton
    Hampshire
    ColombianManaging Director92523390001
    KALB, Frederique
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Diretor
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomFrenchProduct Development Manager172326000001
    KLUTH, Erhard Lothar Edgar, Dr
    The Town Mill
    Mill Lane
    SO24 9DD Alresford
    Hampshire
    Diretor
    The Town Mill
    Mill Lane
    SO24 9DD Alresford
    Hampshire
    CanadianDirector12845860001
    LE FLOCH, Gilles
    Rue Des Bigauds
    78750
    Mareil-Marly
    120
    France
    Diretor
    Rue Des Bigauds
    78750
    Mareil-Marly
    120
    France
    FrenchProduct Development Manager140343550001
    LEGGETT, Nigel
    Barnfell House
    Landford
    SP5 2QP Salisbury
    Diretor
    Barnfell House
    Landford
    SP5 2QP Salisbury
    BritishTechnical Director116531940001
    MARSH, David
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant171331520001
    MARTIN, Rebecca Helen
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    Diretor
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    United KingdomNew ZealanderAcc134158470001
    MCCANN, Dominic Patrick Joseph
    The Dolls House
    Toothill
    SO51 9LN Romsey
    Hampshire
    Diretor
    The Dolls House
    Toothill
    SO51 9LN Romsey
    Hampshire
    EnglandIrishGeneral Manager123011020001
    PARK, Gary
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant270424580001
    PIESSE, Alan Roger
    3 Russet Glade
    Cranmore Lane
    GU11 3BF Aldershot
    Hampshire
    Diretor
    3 Russet Glade
    Cranmore Lane
    GU11 3BF Aldershot
    Hampshire
    BritishSales & Marketing Director44675130001
    PLATT, John Camm
    Meadows
    Martyr Worthy
    SO21 1DZ Winchester
    Hampshire
    Diretor
    Meadows
    Martyr Worthy
    SO21 1DZ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishNon-Executive Chairman8496300002
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Diretor
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant32255250004
    REYNOLDS, John Thomas
    90 Reeters Ridge Road
    IRISH Westport
    06897 Connecticut
    Usa
    Diretor
    90 Reeters Ridge Road
    IRISH Westport
    06897 Connecticut
    Usa
    AmericanVenture Capitalist69090740001
    RIST, Samantha Martha
    School Road
    Bursledon
    SO31 8BY Southampton
    Advent Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    Diretor
    School Road
    Bursledon
    SO31 8BY Southampton
    Advent Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    AmericanManager138420520001
    ROBERSON, Iain Malcolm
    Merry Hills Cottage
    Merry Hills Lane Loxwood
    RH14 0RB Billingshurst
    West Sussex
    Diretor
    Merry Hills Cottage
    Merry Hills Lane Loxwood
    RH14 0RB Billingshurst
    West Sussex
    BritishDirector73503750001
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant134158640002
    TERTYCHNY, Vladimir, Dr
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    United KingdomRussianCenter Manager193152670001
    VARN, Giselle Evette
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    Diretor
    Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate
    Westhill
    AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire
    1
    Scotland
    Scotland
    ScotlandAmericanEur Controller273564740002
    WHITE, Simon Meredith
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Diretor
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Controller130781300001
    WILLIAMS, Glynn Richard
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    Diretor
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director36481970003
    YOUNG, Michael John
    Blairs Culterhouse Road
    Milltimber
    AB13 0EZ Aberdeen
    Scotland
    Diretor
    Blairs Culterhouse Road
    Milltimber
    AB13 0EZ Aberdeen
    Scotland
    BritishNon-Executive Director38513840001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SENSOR HIGHWAY LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Manor Royal
    RH10 9BU Crawley
    Minerva
    United Kingdom
    06/04/2016
    Manor Royal
    RH10 9BU Crawley
    Minerva
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro4157867
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    SENSOR HIGHWAY LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 04/03/2002
    Entregue em 15/03/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    £6,547.25.
    Pessoas com direito
    • Carlton Communications PLC
    Transações
    • 15/03/2002Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 29/09/2000
    Entregue em 12/10/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date (as defined therein)
    Breve descrição
    The sum of £6161.19, an interest bearing account, the amount standing to the credit of the deposit account, all interest credited from time to time.
    Pessoas com direito
    • Carlton Communications PLC
    Transações
    • 12/10/2000Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 27/01/1998
    Entregue em 28/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 26TH september 1997
    Breve descrição
    £4,387.50 plus vat and the amount from time to time standing to the credit of the deposit account and all interest credited to the deposit account from to time. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Carlton Communications PLC
    Transações
    • 28/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 23/08/1996
    Entregue em 29/08/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/08/1996Registro de uma garantia (395)
    • 07/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0