SABA INFRA CARDIFF LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SABA INFRA CARDIFF LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03154700 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
- Outras atividades de apoio ao transporte (52290) / Transportes e armazenagem
Onde fica SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Mazars Llp Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| INDIGO INFRA CARDIFF LIMITED | 05/11/2015 | 05/11/2015 |
| VINCI PARK CARDIFF LIMITED | 04/01/2002 | 04/01/2002 |
| IMPREGILO PARKING (UK) LIMITED | 05/07/1996 | 05/07/1996 |
| IMPREGILO PARKING (UHW) LIMITED | 12/04/1996 | 12/04/1996 |
| IMPREGILO PARKING (HEATH) LIMITED | 28/03/1996 | 28/03/1996 |
| RJT 210 LIMITED | 02/02/1996 | 02/02/1996 |
Quais são as últimas contas de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Michelmores Secretaries Limited Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR para Mazars Llp Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD em 29/07/2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado de Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR United Kingdom para Michelmores Secretaries Limited Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaração de solvência | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Indigo Infra Holdings Uk Limited como pessoa com controlo significativo em 19/12/2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Josep Oriol Carreras como diretor em 17/12/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Wilfried Didier Charles Thierry como diretor em 11/12/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Indigo Infra Holdings Uk Limited como pessoa com controlo significativo em 26/04/2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de , Oak House Reeds Crescent, Watford, Herts, WD24 4QP para Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR em 26/04/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/01/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 02/02/2016 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificado de mudança de nome Company name changed vinci park cardiff LIMITED\certificate issued on 05/11/15 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Michelmores Secretaries Limited como secretário em 12/10/2015 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Quem são os diretores de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKARD, Gary Charles | Secretário | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | 162320950001 | |||||||||||
| MICHELMORES SECRETARIES LIMITED | Secretário | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House England |
| 107218000001 | ||||||||||
| HERRING, Phillip David | Diretor | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | United Kingdom | British | 141247820001 | |||||||||
| ORIOL CARRERAS, Josep | Diretor | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | Spain | Spanish | 253556690001 | |||||||||
| PICKARD, Gary Charles | Diretor | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | United Kingdom | British | 116438300001 | |||||||||
| BARBER, Alistair Michael | Secretário | 13 Foley Road East Streetly Sutton Coldfield B74 3HN Birmingham West Midlands | British | 107070900001 | ||||||||||
| HANKEY, Nicholas | Secretário | Beech Grove HP23 5NU Tring 5 Hertfordshire United Kingdom | British | 128650630001 | ||||||||||
| LOCATELLI, Luigi | Secretário | Flat 1 Lisvane House 66 Mill Road Lisvane CF14 0XN Cardiff South Glamorgan | Italian | 71235150001 | ||||||||||
| TAYLOR, Timothy Robert | Secretário | 56 Grasholm Way Belvedere Place SL3 8WF Langley Berkshire | British | 52404590003 | ||||||||||
| TRISOLINI, Paolo Longobardi | Secretário | 15 Heol Y Bryn Rhiwbina CF4 6HX Cardiff South Glamorgan | Italian | 26794080004 | ||||||||||
| CRESCENT HILL LIMITED | Secretário nomeado | Dumfries House Dumfries Place CF10 3FN Cardiff South Glamorgan | 900004610001 | |||||||||||
| BAGNATI, Pietro | Diretor | 15 Bearfort Court Admirals Landing CF1 5AH Cardiff | Italian | 40476800001 | ||||||||||
| BOUTELIER, Alexandra Florence | Diretor | Reeds Crescent WD24 4QP Watford Oak House Herts United Kingdom | France | French | 156564810001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Martin | Diretor | 243 Burnt Ash Hill Grove Park SE12 0QB London | England | British | 11217230001 | |||||||||
| COMORETTO, Giuseppe | Diretor | Via Gnudi 33 Castiglione Delle Stiniere (Mn)46043 Italy | Italian | 80583690001 | ||||||||||
| CORTI, Riccardo | Diretor | Viale Italia 1 Sesto San Giovanni FOREIGN Milan Italy | Italian | 56392580002 | ||||||||||
| EVANS, Mark Robert | Diretor | Painswick Road GL50 2ER Cheltenham 40 Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 70616050011 | |||||||||
| HANKEY, Nicholas | Diretor | Beech Grove HP23 5NU Tring 5 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 128650630001 | |||||||||
| KALIS, Maximilian | Diretor | Reeds Crescent WD24 4QP Watford Oak House Herts United Kingdom | Germany | German | 151018260001 | |||||||||
| LOCATELLI, Luigi | Diretor | Flat 1 Lisvane House 66 Mill Road Lisvane CF14 0XN Cardiff South Glamorgan | Italian | 71235150001 | ||||||||||
| MARTIN, Anthony Cedric Guy | Diretor | 12 Avenue Du Pavillon Sully 78230 Le Pecq France | French | 78144090002 | ||||||||||
| MORELLO MOSTO, Cesare Arturo | Diretor | 7 Clive Crescent CF64 1AT Penarth Vale Of Glamorgan | Italian | 69559250001 | ||||||||||
| POUSSIN, Claude | Diretor | 174 Rue De Courcelles FOREIGN 75017 Paris France | French | 56111040001 | ||||||||||
| PRINCET, Philippe Pierre Edouard | Diretor | 13 Avenue Robert Andre Vivien 94160 Saint Mande France | France | French | 70956330002 | |||||||||
| TAYLOR, Susan Jane | Diretor | Oswald London Road SL5 9RY Sunningdale Berks | Great Britain | British | 114425830001 | |||||||||
| TAYLOR, Timothy Robert | Diretor | 56 Grasholm Way Belvedere Place SL3 8WF Langley Berkshire | British | 52404590003 | ||||||||||
| THIERRY, Wilfried Didier Charles | Diretor | Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 61 France | France | French | 169088870001 | |||||||||
| THIERRY, Wilfried Didier Charles | Diretor | 35 Rue Grande Puiselet 77140 Saint Pierre Les Nemours Paris France | France | French | 169088870001 | |||||||||
| ST ANDREWS COMPANY SERVICES LIMITED | Diretor nomeado | Dumfries House Dumfries Place CF10 3FN Cardiff South Glamorgan | 900004600001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saba Infra Holdings Uk Limited | 06/04/2016 | Reeds Crescent WD24 4PH Watford Oak House Herts England | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
| |||||||
SABA INFRA CARDIFF LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 07/07/2014 Entregue em 15/07/2014 | Totalmente satisfeita | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Security agreement | Criado em 09/10/2003 Entregue em 15/10/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição First legal mortgage l/h premises comprising two purpose built carparks at the university hospital of wales with all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery, benefit of any covenants, insurances in relation to english mortgaged property, assigns all its right in respect of each relevant contract fixed charge the benefit of any authorisation held in connection with its use of any security asset. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 19/12/1996 Entregue em 09/01/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company (as borrower) to the chagee under the terms of the facility agreement dated 6TH september 1996 and this charge | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
SABA INFRA CARDIFF LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0