EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03170995 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
- Outro arrendamento e exploração de imóveis próprios ou arrendados (68209) / Atividades imobiliárias
Onde fica EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Sevendale House 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Greater Manchester United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| FLAGSHIP CARE (SURREY) LIMITED | 09/05/1997 | 09/05/1997 |
| BROOMCO (1051) LIMITED | 12/03/1996 | 12/03/1996 |
Quais são as últimas contas de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/03/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2018 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/03/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ England para Sevendale House 3rd Floor, Suite 6C 5-7 Dale Street Manchester Greater Manchester M1 1JB em 06/11/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Emma Margaret Clarke como secretário em 16/10/2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de David Thomas Adams como secretário em 16/10/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 10-11 Welken House Charterhouse Square London EC1M 6EH England para 5th Floor 120 Aldersgate Street London EC1A 4JQ em 05/10/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2017 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/03/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David Thomas Adams como secretário em 12/10/2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Gordon Neil Springett como secretário em 12/10/2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Robert Alistair Martin Gillespie como diretor em 05/07/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jennifer Louise Crouch como diretor em 05/07/2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 12/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 12/03/2016 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Richard Daniel Knight como diretor em 01/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Sion Laurence Jones como diretor em 01/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Ms Jennifer Louise Crouch como diretor em 01/04/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Philip Arthur Would como diretor em 01/04/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Quem são os diretores de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Emma Margaret | Secretário | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | 251514980001 | |||||||
| GILLESPIE, Robert Alistair Martin | Diretor | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | England | British | 230652780001 | |||||
| WOULD, Philip Arthur | Diretor | 3rd Floor, Suite 6c 5-7 Dale Street M1 1JB Manchester Sevendale House Greater Manchester United Kingdom | England | British | 157945610001 | |||||
| ADAMS, David Thomas | Secretário | 120 Aldersgate Street EC1A 4JQ London 5th Floor England | 238967880001 | |||||||
| CROSSLEY, Hugh Barnabas | Secretário | Stonebridge House Wiveton NR25 7TP Holt Norfolk | British | 107284040001 | ||||||
| HANDLEY, David Michael | Secretário | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | British | 52899270001 | ||||||
| PINNINGTON, Ian Harry | Secretário | Shillingford Bucklow View Bowdon WA14 3JP Altrincham Cheshire | British | 11801040001 | ||||||
| SMITH, Jonathan Charles | Secretário | c/o King Sturge Finance Warwick Street W1B 5NH London 30 United Kingdom | British | 127121960001 | ||||||
| SPRINGETT, Gordon Neil | Secretário | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | 169292500001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário nomeado | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| CHRITSTIE, Rory William | Diretor | c/o King Sturge Finance Warwick Street W1B 5NH London 30 United Kingdom | United Kingdom | British | 152827480001 | |||||
| CROUCH, Jennifer Louise | Diretor | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | England | British | 199682550001 | |||||
| HANDLEY, David Michael | Diretor | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | United Kingdom | British | 52899270001 | |||||
| HARRIS, John David | Diretor | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | England | British | 174333200001 | |||||
| JACKSON, Geoffrey Allan | Diretor | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | United Kingdom | British | 79174450001 | |||||
| JONES, Sion Laurence | Diretor | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | United Kingdom | English | 137554960001 | |||||
| KNIGHT, Richard Daniel | Diretor | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 Welken House England | United Kingdom | British | 162323970001 | |||||
| MADDIN, Keith John | Diretor | 27 Wayneflete Tower Avenue KT10 8QQ Esher Surrey | United Kingdom | British | 141926560001 | |||||
| NUTTALL, Lennard Joseph | Diretor | 90 Moss Lane BL1 6LY Bolton | England | British | 51238440001 | |||||
| OLDHAM, James William | Diretor | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London | Uk | British | 127121570001 | |||||
| PAYNE, Richard William Norris | Diretor | Harland House Harland Way, Southborough TW4 0TQ Tunbridge Wells Kent | British | 77845170001 | ||||||
| RICHARDSON, Philip | Diretor | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 81186940003 | ||||||
| SALISBURY, Nicholas William | Diretor | Barclays Bank Plc 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 4380320005 | |||||
| SEDDON, Christopher John | Diretor | 88 Roe Green Worsley M28 2RN Manchester | United Kingdom | British | 3813770002 | |||||
| TINDALL, Terence William | Diretor | 19 Oak Tree Close GU25 4JF Virginia Water Surrey | England | British | 4380330001 | |||||
| WHITAKER, Jack Leeming | Diretor | Highcroft Foxholes Road Horwich BL6 6AL Bolton Greater Manchester | British | 24399020001 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Diretor nomeado | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitix Healthcare Limited | 01/03/2017 | Charterhouse Square EC1M 6EH London 10-11 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
EQUITIX HEALTHCARE (SURREY) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 18/12/2007 Entregue em 22/12/2007 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road coulsden t/no SY47077 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Criado em 11/12/1998 Entregue em 29/12/1998 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição In retentions account number 40652857. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Criado em 11/12/1998 Entregue em 29/12/1998 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Account number 30440701. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 29/03/1996 Entregue em 12/04/1996 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Land on the north side of lower park road and on the west side of chipstead valley road, coulsdon t/no. SY47077 and all buildings and fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0