SPORTING LIFE UK LIMITED

SPORTING LIFE UK LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSPORTING LIFE UK LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03177760
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SPORTING LIFE UK LIMITED?

    • (9251) /
    • (9262) /

    Onde fica SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PA SPORTING LIFE LIMITED29/11/199629/11/1996
    PA WEATHERBYS RACING COMMUNICATIONS LIMITED17/06/199617/06/1996
    DIPLEMA 324 LIMITED26/03/199626/03/1996

    Quais são as últimas contas de SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2010

    Quais são as últimas submissões para SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    4 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 24/03/2012

    4 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de Grant Way Isleworth Middlesex TW7 5QD em 13/04/2011

    1 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 25/03/2011

    LRESSP

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de Christopher Jon Taylor como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de David Joseph Gormley como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Richard Flint como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Simon Steele como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Piers Croton como diretor

    2 páginasTM01

    Estado do capital em 18/02/2011

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 14/02/2011

    • Capital: GBP 18,266,902
    4 páginasSH01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 01/02/2011 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2010

    20 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/02/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2009

    20 páginasAA

    Nomeação de Simon Naunton Steele como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Vincent Russell como diretor

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 30/06/2008

    25 páginasAA

    Quem são os diretores de SPORTING LIFE UK LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GORMLEY, David Joseph
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Secretário
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    British150780210001
    GORMLEY, David Joseph
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Diretor
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Secretary150780210001
    TAYLOR, Christopher Jon
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Diretor
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Secretary135143490001
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Secretário
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    BritishManaging Director Chartered Ac3379480001
    GALVIN, Andrew Michael
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    Secretário
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector49667690003
    KENNEDY, Christina Lillian
    Walnut House
    Walnut Gardens Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    Secretário
    Walnut House
    Walnut Gardens Claydon
    OX17 1NA Banbury
    Oxfordshire
    BritishSecretary7909160003
    MARJORIBANKS, Richard John Bradley
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    Secretário
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    British56196620001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Secretário nomeado
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    ADSHEAD, Vivienne
    The Old Chapel
    Tong Park, Baildon
    BD17 7QH Shipley
    West Yorkshire
    Diretor
    The Old Chapel
    Tong Park, Baildon
    BD17 7QH Shipley
    West Yorkshire
    BritishCommercial Director68166530001
    ALLWOOD, Charles John
    Park Farm The Twist
    Wigginton
    HP23 6DU Tring
    Hertfordshire
    Diretor
    Park Farm The Twist
    Wigginton
    HP23 6DU Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director35681240003
    ANNAT, David Christie
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    Diretor
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    BritishCompany Director2145940001
    ANNAT, David Christie
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    Diretor
    Watergap
    Dig Street
    SK17 0AQ Hartington
    Derbyshire
    BritishManaging Director2145940001
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Diretor
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director3379480001
    CROTON, Piers Maitland Adrian
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Diretor
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    BritishDirector36253150002
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    Diretor
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    SwitzerlandBritishDirector153016810001
    EWING, Margaret
    Maraval
    Hamm Court
    KT13 8YG Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Maraval
    Hamm Court
    KT13 8YG Weybridge
    Surrey
    BritishFinancial Director68009020001
    FLINT, Richard
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Diretor
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    BritishCompany Director103872130004
    GALVIN, Andrew Michael
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    Diretor
    North Longlands Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8JN Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector49667690003
    GRIFFITH, Andrew John
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    Diretor
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    Middlesex
    United KingdomBritishChief Financial Officer129926510001
    NORRIS, John Lionel
    Roseland 42 Debdale Road
    NN8 5AJ Wellingborough
    Northamptonshire
    Diretor
    Roseland 42 Debdale Road
    NN8 5AJ Wellingborough
    Northamptonshire
    United KingdomBritishBusiness Executive15693810004
    PEREIRA, Alan Dennis
    30 Kingscliffe Gardens
    SW19 6NR London
    Diretor
    30 Kingscliffe Gardens
    SW19 6NR London
    BritishDirector61856670002
    POTTS, Paul John
    Western Gardens
    Ealing
    W5 3RU London
    26
    Diretor
    Western Gardens
    Ealing
    W5 3RU London
    26
    United KingdomBritishChief Executive43329700002
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Diretor nomeado
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British900005030001
    REED, Jeremy Peter
    Palletts Farmhouse
    High Street
    CB11 3PE Newport
    Essex
    Diretor
    Palletts Farmhouse
    High Street
    CB11 3PE Newport
    Essex
    BritishManaging Director94644540001
    RIKLIN, Cornel Carl
    11 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Diretor
    11 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    BritishCompany Director50935910001
    RUSSELL, Vincent Harvey
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    Diretor
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Group Plc
    Middlesex
    United KingdomBritishAccountant168038230001
    RUST, Nicholas John
    2 Manor Court
    Little Ouseburn
    YO26 9TB York
    North Yorkshire
    Diretor
    2 Manor Court
    Little Ouseburn
    YO26 9TB York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director112088680001
    SEMEL, Eric
    33 Chesham Street Flat 8
    SW1X 8NQ London
    Diretor
    33 Chesham Street Flat 8
    SW1X 8NQ London
    AmericanDirector102427690001
    SHERWOOD, Barrie John
    1 Lodge Road
    Sharnbrook
    MK44 1JB Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    1 Lodge Road
    Sharnbrook
    MK44 1JB Bedford
    Bedfordshire
    BritishAccountant13479190001
    SIMPSON, Robert Brian
    1 Combe Royal Crescent
    BA2 6EZ Bath
    Avon
    Diretor
    1 Combe Royal Crescent
    BA2 6EZ Bath
    Avon
    BritishChief Executive100368690001
    STEELE, Simon Naunton
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Plc
    Middlesex
    Diretor
    Grant Way
    TW7 5QD Isleworth
    British Sky Broadcasting Plc
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant220122710001
    WEATHERBY, Jonathan Roger, Sir
    Preston Lodge
    Withcote
    LE15 8DP Oakham
    Leicestershire
    Diretor
    Preston Lodge
    Withcote
    LE15 8DP Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritishBusiness Executive10579020003
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Diretor nomeado
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001

    SPORTING LIFE UK LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 14/10/2004
    Entregue em 21/10/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 21/10/2004Registro de uma garantia (395)
    • 24/01/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Memorandum of variation
    Criado em 03/03/2000
    Entregue em 22/03/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    To the chargee the amount secured by a secured loan note dated 28 june 1996 and granted by the company in favour of weatherbys group limited as varied by a memorandum of variation dated 28 november 1996 and as further varied by this memorandum of variation is £1,085,000 and such additional sums (up to a further £415,000) as may be advanced under the terms of the secured loan note
    Breve descrição
    The property charge is that charged by the secured loan note as described in the form 395 for such loan note as registered on the 8/7/96.
    Pessoas com direito
    • Mgn Limited(Pursuant to an Assignment from Weatherbys Group Limited Dated 28 November 1996)
    Transações
    • 22/03/2000Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Memorandum of variation
    Criado em 03/03/2000
    Entregue em 22/03/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    To the chargee the amount secured by a secured loan note dated 28 june 1996 and granted by the company in favour of ananova limited (formerly pa news limited) as varied by a memorandum of variation and as further varied by this memorandum of variation is £1,085,000 and such additional sums (up to a further £415,000) as may be advanced under the terms of the secured loan note
    Breve descrição
    The property charged is that charged by the secured loan note as described in the form 395 for such loan note as registered on the 15/7/96.
    Pessoas com direito
    • The Press Association Limited(Pursuant to an Assignment from Ananova Limiteddated 3 March 2000)
    Transações
    • 22/03/2000Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Memorandum of variation
    Criado em 28/11/1996
    Entregue em 18/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £350,000 due or to become from the company to the chargee
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Pa News Limited
    Transações
    • 18/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Secured loan note
    Criado em 28/06/1996
    Entregue em 15/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £250,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Pa News Limited
    Transações
    • 15/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Secured loan note
    Criado em 28/06/1996
    Entregue em 08/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the secured loan note
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Weatherbys Group Limited
    Transações
    • 08/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    SPORTING LIFE UK LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    11/01/2013Data de dissolução
    25/03/2011Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0