THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED

THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTHE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03183931
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    55 Wells Street
    W1A 3AE London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CLASSTYPIST LIMITED10/04/199610/04/1996

    Quais são as últimas contas de THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 10/04/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA England para 55 Wells Street London W1A 3AE em 09/04/2018

    1 páginasAD01

    Cessação de Richard Stanley Coward como pessoa com controlo significativo em 15/03/2018

    1 páginasPSC07

    Notificação de Stephen James Faulkner como pessoa com controlo significativo em 15/03/2018

    2 páginasPSC01

    Término da nomeação de Richard Stanley Coward como diretor em 15/03/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen James Faulkner como diretor em 15/03/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Stuart Dudley Trood como diretor em 30/11/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jane Li como secretário em 30/11/2017

    1 páginasTM02

    Cessação de Stuart Dudley Trood como pessoa com controlo significativo em 30/11/2017

    1 páginasPSC07

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 02/06/2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel £15132160 from share prem a/c 11/05/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 10/04/2017 com atualizações

    6 páginasCS01

    Término da nomeação de Andrea Lattimore como diretor em 22/08/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jeremy Hamilton Hook como diretor em 22/08/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Andrew James Gunton como diretor em 22/08/2016

    1 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de 29 st John's Lane London EC1M 4NA para Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA em 01/06/2016

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 10/04/2016 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/04/2016

    Estado do capital em 22/04/2016

    • Capital: GBP 1,555,840
    SH01

    Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/12/2015

    3 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Stuart Dudley Trood em 01/07/2012

    2 páginasCH01

    Quem são os diretores de THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FAULKNER, Stephen James
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    Diretor
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    EnglandIrishCompany Director190049190002
    DELL, Richard Frederick
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    Secretário
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    BritishAccountant74124260001
    DUNCAN, William Grant
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    Secretário
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    BritishLegal Director75956440002
    JEAKINGS, Adrian Dion
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    Secretário
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    BritishDirector63331450001
    LI, Jane
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    Secretário
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Company Secretary
    Berkshire
    England
    202676540001
    MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    Secretário
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    BritishFinance Director50277810002
    THIAN, Robert Peter
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    Secretário
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    BritishCompany Director41949700001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro817717
    32524900007
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BONNAR, John Niven
    The Red House
    Wyre Lane, Long Marston
    CV37 8RQ Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Diretor
    The Red House
    Wyre Lane, Long Marston
    CV37 8RQ Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director113933000001
    COWARD, Richard Stanley
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Diretor
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    United KingdomBritishCfo199946190001
    DELL, Richard Frederick
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    Diretor
    12 Corton Road
    NR32 4PL Lowestoft
    Suffolk
    United KingdomBritishAccountant74124260001
    FIELD, Malcolm, Sir
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    Diretor
    15 Eaton Terrace
    SW1W 9DD London
    BritishChairman Caa74857040001
    GUNTON, Andrew James
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Diretor
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishDirector201996600001
    HAILSTONE, Timothy Martin
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    Diretor
    The White Cottage Ivy Bank
    Swannaton Road
    TQ6 9RL Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director62539790001
    HOOK, Jeremy Hamilton
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Diretor
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishDirector80045690001
    JEAKINGS, Adrian Dion
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    Diretor
    466a Unthank Road
    NR4 7QJ Norwich
    Norfolk
    UkBritishDirector63331450001
    LATTIMORE, Andrea
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Diretor
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishRisk Director190074140001
    MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    Diretor
    Weavers Mark The Green
    Palgrave
    IP22 1AN Diss
    Norfolk
    BritishFinance Director50277810002
    MIDDLETON, Rupert John
    80 Mortimer Road
    N1 5AP London
    Diretor
    80 Mortimer Road
    N1 5AP London
    United KingdomBritishDirector27908530001
    PARTRIDGE, Michael John Anthony
    27 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    Diretor
    27 High View
    HA5 3NZ Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishDirector28205070001
    PENNANT-REA, Rupert Lascelles
    59 Cranmer Court
    Whiteheads Grove
    SW3 3HW London
    Diretor
    59 Cranmer Court
    Whiteheads Grove
    SW3 3HW London
    UkBritishBusinessman44312900002
    PERKINS, Frederick James
    25 Ham Farm Road
    TW10 5NA Richmond
    Surrey
    Diretor
    25 Ham Farm Road
    TW10 5NA Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChief Executive27861770001
    PIERLEONI, Marco Alessandro
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    Diretor
    St John's Lane
    EC1M 4NA London
    29
    England
    EnglandBritishCeo Williams Lea Public Sector133649430001
    PIPER, Paul James
    4 Brindle Gate
    DA15 8BU Sidcup
    Kent
    Diretor
    4 Brindle Gate
    DA15 8BU Sidcup
    Kent
    BritishDirector63643370001
    SYDER, Timothy Dominic James
    21 Baskerville Road
    SW18 3RW London
    Diretor
    21 Baskerville Road
    SW18 3RW London
    BritishChartered Accountant2059980002
    THIAN, Robert Peter
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    Diretor
    15a Princes Gate Mews
    SW7 2PS London
    BritishCompany Director41949700001
    TOULSON CLARKE, Christopher Timothy Miles
    Tree Tops
    Great Elm
    BA11 3NZ Frome
    Somerset
    Diretor
    Tree Tops
    Great Elm
    BA11 3NZ Frome
    Somerset
    United KingdomBritishDirector45455220003
    TROOD, Stuart Dudley
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Diretor
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer138486040005
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quem são as pessoas com controle significativo de THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Mr Stephen James Faulkner
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    15/03/2018
    Wells Street
    W1A 3AE London
    55
    England
    Não
    Nacionalidade: Irish
    País de residência: England
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.
    Mr Richard Stanley Coward
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    10/04/2017
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Sim
    Nacionalidade: British
    País de residência: United Kingdom
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.
    Mr Stuart Dudley Trood
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    10/04/2017
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    England
    Sim
    Nacionalidade: British
    País de residência: England
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

    THE STATIONERY OFFICE GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 20/07/2000
    Entregue em 02/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by the stationery office holdings limited under the deep discount bond instrument
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Apax Partners & Co. Ventures Limitedas Security Trustee for the Security Beneficiaries (The "Security Trustee")
    Transações
    • 02/08/2000Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 20/07/2000
    Entregue em 02/08/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company and/or any group company to the security benficiaries which is for the time being a party to any security document whether pursuant to the guarantee or otherwise (all as defined therein)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 02/08/2000Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 22/09/1999
    Entregue em 29/09/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due to the security beneficiaries (as defined) by any charging company and/or any group company (both as defined) in any manner whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transações
    • 29/09/1999Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 01/04/1999
    Entregue em 16/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness,liabilities and obligations which are as at 1ST april 1999 or may at any time thereafter be due,owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) and to the security beneficiaries (as defined) by any charging company whether actually or contingently whether pursuant to the guarantee or otherwise,whether solely or jointly with any other person and whether or not the security beneficiaries shall have been an original party to the relevant transaction and in whatever currency denominated including all liabilities in connection with foreign exchange transactions,acceptances,discounting or otherwise or under guarantees,bonds,idemnities,documentary or amy instruments whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 30/09/1996
    Entregue em 04/10/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any charging company (as defined) to the chargee whether actually or contingently (but excluding any such indebtedness, liabilities and obligations which would constitute financial assistance, as defined in and prohibited by sections 151, 152 and 154 of the companies act 1985, which has not been given in accordance with sections 155-158 of the companies act 1985 or is not prohibited by section 153 of the companies act 1985), whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descrição
    1. each charging company charged to the security trustee (for the benefit of the security beneficiaries) by way of first legal mortgage:- 1.1 all its f/h and l/h interest in the properties being, (a) 51 nine elms lane, battersea t/n-sgl 253405. (b) land at willow walk, mandela way, southwark SE1 t/n-sgl 393821. (c) garage at coed-yr-ynn rhiwbina cardiff t/n-wa 651192.. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transações
    • 04/10/1996Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0