TRINITY CARE HOMES LIMITED

TRINITY CARE HOMES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTRINITY CARE HOMES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03184056
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    • Outras atividades de saúde humana (86900) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    STONEYFORD CHRISTIAN NURSING HOME LIMITED06/09/199606/09/1996
    AYCEECO (140) LIMITED10/04/199610/04/1996

    Quais são as últimas contas de TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/09/2010

    Quais são as últimas submissões para TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário em 09/10/2012

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Timothy James Bolot como diretor em 31/08/2012

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Charles Lovett como diretor em 31/08/2012

    2 páginasAP01

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    6 páginas1.4

    Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor

    4 páginas1.1

    Declaração anual preparada até 10/04/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/04/2012

    Estado do capital em 10/04/2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Término da nomeação de William James Buchan como diretor em 15/11/2011

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Andrew Smith como diretor em 01/11/2011

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Stephen Jonathan Taylor como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Timothy James Bolot como diretor em 26/10/2011

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 30/09/2010

    19 páginasAA

    Declaração anual preparada até 10/04/2011 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01

    Nomeação de Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de William Mcleish como secretário

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Richard Midmer como diretor

    1 páginasTM01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Explanatory statment to sole member 14/05/2010
    RES13

    Declaração anual preparada até 10/04/2010 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 27/09/2009

    17 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr David Andrew Smith em 07/01/2010

    2 páginasCH01

    Nomeação de um diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr David Andrew Smith como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Kamma Foulkes como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de TRINITY CARE HOMES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Diretor
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretário
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British84003280001
    LONG, Anne Marguerite Dorothy
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    Secretário
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    British43180700001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158661940001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretário
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretário
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Diretor
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    British51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Diretor
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Diretor
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Diretor
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritish93592160001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish84003280001
    HENDERSON, David Greig
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    Diretor
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    EnglandBritish6112570002
    HILL, Randolph Paul
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Diretor
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15223790003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Diretor
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    LONG, Anne Marguerite Dorothy
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    Diretor
    Flat 6 107 Metchley Lane
    Harborne
    B17 0HP Birmingham
    British43180700001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Diretor
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Diretor
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Diretor
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Diretor
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Diretor
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    United KingdomBritish124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Diretor
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Diretor
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Diretor
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Diretor
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Diretor
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    British34214100001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Diretor
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish80445640001
    WEARING, John Howard
    56 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    56 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish46626990001

    TRINITY CARE HOMES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A supplemental debenture
    Criado em 29/10/1999
    Entregue em 03/11/1999
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. 1 Limited
    Transações
    • 03/11/1999Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 11/04/1997
    Entregue em 23/04/1997
    Pendente
    Montante garantido
    All sums payable by the company to the chargee in the event of default (as defined) under the terms of a lease dated 4TH february 1997
    Breve descrição
    The initial deposit means the sum equivalent to twice the basic rent (as defined) and interest which means all interest credited to the deposit account. Deposit account means an interest bearing deposit account at such bank or institution as the landlord shall from time to time decide.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transações
    • 23/04/1997Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 11/04/1997
    Entregue em 22/04/1997
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a default
    Breve descrição
    The company with full title guarantee charges the initial deposit,all interest,the deposit account being an interest bearing account specifically designated "deposit account" at such bank or institution as the chargee (landlord) shall from time to time decide in it's absolute discretion and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.1 PLC
    Transações
    • 22/04/1997Registro de uma garantia (395)
    Mortgage debenture
    Criado em 03/02/1997
    Entregue em 06/02/1997
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Property k/a chandlers ford christian nursing home winchester road chandlers ford eastleigh hampshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. I PLC
    Transações
    • 06/02/1997Registro de uma garantia (395)
    Mortgage debenture
    Criado em 28/11/1996
    Entregue em 14/12/1996
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    First fixed charge on l/hold premises at stoneyford nursing home,stoneyford rd,sutton in ashfield,nottinghamshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No.I PLC
    Transações
    • 14/12/1996Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 28/11/1996
    Entregue em 10/12/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default
    Breve descrição
    The deposit as defined on the reverse of the form 395.
    Pessoas com direito
    • Nhp Securities No. 1 PLC
    Transações
    • 10/12/1996Registro de uma garantia (395)
    • 22/07/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    TRINITY CARE HOMES LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    20/06/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    20/08/2012Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Profissional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0