CONNAUGHT PLC

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCONNAUGHT PLC
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade anónima cotada
    Número da empresa 03184319
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CONNAUGHT PLC?

    • (4525) /
    • (7415) /

    Onde fica CONNAUGHT PLC?

    Endereço do escritório registrado
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CONNAUGHT PLC?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CONNAUGHT HOLDINGS LIMITED29/05/199629/05/1996
    BONDCO 611 LIMITED11/04/199611/04/1996

    Quais são as últimas contas de CONNAUGHT PLC?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/08/2009

    Quais são as últimas submissões para CONNAUGHT PLC?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Notificação da conta final antes da dissolução

    21 páginasWU15

    Relatório de progresso numa liquidação pelo tribunal

    20 páginasWU07

    Relatório de progresso numa liquidação pelo tribunal

    19 páginasWU07

    Aviso de destituição do liquidatário pelo tribunal

    10 páginasWU14

    Nomeação de um liquidatário

    3 páginasWU04

    Pedido de insolvência

    Insolvency:liquidators annual progress report to 24/02/2017
    17 páginasLIQ MISC

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 páginasLIQ MISC

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2016
    14 páginasLIQ MISC

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:liquidators annual progress report compulsory liquidation bdd 24/02/2015
    15 páginasLIQ MISC

    Endereço do domicílio registado alterado de Kpmg 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB para Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL em 08/04/2015

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidatário

    1 páginas4.31

    Ordem do tribunal para liquidar

    3 páginasCOCOMP

    Relatório de progresso do administrador até 25/02/2014

    25 páginas2.24B

    Aviso de ordem judicial terminando a administração

    1 páginas2.33B

    Relatório de progresso do administrador até 25/02/2014

    25 páginas2.24B

    Aviso de ordem judicial terminando a administração

    25 páginas2.33B

    Relatório de progresso do administrador até 12/12/2013

    24 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 12/12/2013

    21 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 12/06/2013

    21 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 12/06/2013

    21 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 12/06/2013

    21 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 12/12/2012

    22 páginas2.24B

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Relatório de progresso do administrador até 12/12/2012

    22 páginas2.24B

    Quem são os diretores de CONNAUGHT PLC?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Secretário
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British140133020001
    HILL, Stephen Ronald
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Diretor
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish115233060001
    ROSS, Timothy Stuart
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Diretor
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    EnglandBritish33564830003
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Secretário
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Secretário
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    British64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Secretário
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    British99914770001
    WELLS, David Francis
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    Secretário
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    British104366980002
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Secretário nomeado
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005060001
    ALCOCK, Robert Harding
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Diretor
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish9764400003
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Diretor
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritish99584240001
    DARKIN, Andrew
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    Diretor
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    United KingdomBritish137575700001
    DAVIES, Mark Dingad
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Diretor
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish203044250004
    EVANS, Terence Mervin
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    Diretor
    The Cottage Meare Green
    Stoke St Gregory
    TA3 6HY Taunton
    Somerset
    British47913740001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Diretor
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    HENRY, Robert Michael
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    Diretor
    9 Hollydale Drive
    BR2 8QL Bromley
    Kent
    United KingdomBritish36661900001
    MCLAUGHLIN, James, Mr.
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    Diretor
    Snow Meadow Barn
    Middle Stoughton
    BS28 4PT Wedmore
    Somerset
    UkBritish107447050001
    MCNAUGHTON, Andrew Robert Paul
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    Diretor
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    British53282280004
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Diretor
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    EnglandBritish64426280002
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Diretor
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritish99914770001
    PRICE, Caroline Fiona
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Diretor
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritish38883480011
    SMITH, Richard David
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    Diretor
    Horrells Idestone
    Longdown
    EX6 7BL Exeter
    Devon
    British17374050001
    STANDING, Roger
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    Diretor
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    British47913670001
    TINCKNELL, Mark William
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Diretor
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    EnglandBritish4088810003
    WELLS, David Francis
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    Diretor
    Rosewood House
    Bakers Corner
    SN13 9SY Neston
    Wiltshire
    British104366980001
    WILLIAMS, Anthony John
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    Diretor
    Foresters Lodge School Lane
    Bawdsey
    IP12 3AR Woodbridge
    Suffolk
    British81797450001
    BONDLAW DIRECTORS LIMITED
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    Diretor nomeado
    Darwin House
    Southernhay Gardens
    Exeter
    Devon
    900005050001

    CONNAUGHT PLC possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A mortgage of shares agreement
    Criado em 26/11/2009
    Entregue em 01/12/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    First equitable mortgage all the shares.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 01/12/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Mortgage of shares agreement
    Criado em 14/11/2009
    Entregue em 25/11/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The shares including all related rights see image for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 25/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Mortgage of shares
    Criado em 14/11/2009
    Entregue em 24/11/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of a first equitable mortgage all shares see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Trustee
    Transações
    • 24/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Rent deposit deed
    Criado em 15/09/2009
    Entregue em 21/09/2009
    Pendente
    Montante garantido
    £1,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Bank deposit of £1,000.00.
    Pessoas com direito
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transações
    • 21/09/2009Registro de uma garantia (395)
    Mortgage of shares
    Criado em 06/08/2009
    Entregue em 25/08/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transações
    • 25/08/2009Registro de uma garantia (395)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Security agreement
    Criado em 06/08/2009
    Entregue em 25/08/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transações
    • 25/08/2009Registro de uma garantia (395)
    • 08/10/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Shares pledge
    Criado em 06/08/2009
    Entregue em 26/08/2009
    Pendente
    Montante garantido
    Each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Pledges and assigns to the security trustee its whole right title interest and benefit in and to the charged assets the shares being 100 shares of £1 each in the share capital of the company the dividends see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes
    Transações
    • 26/08/2009Registro de uma garantia (395)
    Security agreement
    Criado em 10/07/2009
    Entregue em 23/07/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transações
    • 23/07/2009Registro de uma garantia (395)
    • 08/10/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Share pledge
    Criado em 10/07/2009
    Entregue em 28/07/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Its whole right, title interest and benefit in to the charged assets:the charged assets means the shares and all stocks being 100 ordinary shares of £1.00 each see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transações
    • 28/07/2009Registro de uma garantia (395)
    Mortgage of shares
    Criado em 10/07/2009
    Entregue em 23/07/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transações
    • 23/07/2009Registro de uma garantia (395)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Scottish shares pledge
    Criado em 10/07/2009
    Entregue em 25/07/2009
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Whole right title and interest in and to the charged assets being the 100 ordinary shares of £1 each in connaught property services (glasgow) limited and the related rights. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transações
    • 25/07/2009Registro de uma garantia (395)
    Mortgage of shares agreement
    Criado em 19/10/2007
    Entregue em 31/10/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the shares and all interest in the shares including all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transações
    • 31/10/2007Registro de uma garantia (395)
    Share plegde agreement
    Criado em 21/08/2007
    Entregue em 05/09/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The shares and all stocks,shares,warrants,securitites,rights,money or property,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transações
    • 05/09/2007Registro de uma garantia (395)
    A security agreement
    Criado em 17/08/2007
    Entregue em 31/08/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transações
    • 31/08/2007Registro de uma garantia (395)
    • 08/10/2010Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    A mortgage of shares agreement
    Criado em 17/08/2007
    Entregue em 31/08/2007
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All the shares owned by it (including all related rights). See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transações
    • 31/08/2007Registro de uma garantia (395)
    • 11/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Guarantee & debenture
    Criado em 13/12/2006
    Entregue em 16/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 16/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 04/08/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 01/09/2006
    Entregue em 07/09/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,000.00 due or to become due from the company to
    Breve descrição
    Charge of £1,000.00 deposit account and other monies due under a lease. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transações
    • 07/09/2006Registro de uma garantia (395)
    • 10/03/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 17/05/2004
    Entregue em 20/05/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transações
    • 20/05/2004Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Criado em 21/08/2002
    Entregue em 24/08/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All such sums together with interest and other amounts accruing on such sums for the time being standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00899263 of the company with the chargee.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 24/08/2002Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Criado em 09/05/2002
    Entregue em 10/05/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All such sums together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061 of the company together with all the present and future right title and benefit of the company whatsoever in the deposit.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 10/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Criado em 28/03/2002
    Entregue em 13/04/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Sums for the time being and from time to time standing to the credit of or allocated to the blocked or designated account number 00245061. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/04/2002Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/12/2000
    Entregue em 22/12/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 22/12/2000Registro de uma garantia (395)
    • 04/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Criado em 03/11/2000
    Entregue em 10/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 10/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge of deposit
    Criado em 01/07/1999
    Entregue em 08/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All deposits now and in the future credited to account desingation 21213201 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or part from such deposits or account.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 08/07/1999Registro de uma garantia (395)
    • 22/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 26/06/1996
    Entregue em 01/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 01/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 04/08/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CONNAUGHT PLC possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    08/09/2010Início da administração
    07/03/2014Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    17/09/2019Conclusão da liquidação
    05/02/2014Data da petição
    25/02/2014Início da liquidação
    04/03/2020Data de dissolução
    Liquidação compulsória
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profissional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profissional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Paul Nicholas Dumbell
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Profissional
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0