RIBBON HOTELS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRIBBON HOTELS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03203484
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RIBBON HOTELS LIMITED?

    • Hotéis e alojamentos semelhantes (55100) / Alojamento, restauração e similares

    Onde fica RIBBON HOTELS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RIBBON HOTELS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LRG HOTELS LIMITED26/05/200526/05/2005
    INTERCONTINENTAL HOTELS LIMITED 16/04/200316/04/2003
    SIX CONTINENTS HOTELS LIMITED16/07/200216/07/2002
    POSTHOUSE HOTELS LIMITED06/11/199606/11/1996
    POST HOUSES LIMITED19/07/199619/07/1996
    865TH SHELF TRADING COMPANY LIMITED24/05/199624/05/1996

    Quais são as últimas contas de RIBBON HOTELS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para RIBBON HOTELS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    17 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/11/2018

    16 páginasLIQ03

    Término da nomeação de Justin Bruce Robinson como diretor em 14/09/2018

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 032034840018

    4 páginasMR04

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 22/12/2017

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    6 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 30/11/2017

    LRESSP

    Detalhes do secretário alterados para Haysmacintyre Company Secretaries Limited em 18/12/2017

    1 páginasCH04

    Detalhes do diretor alterados para Mr Patrick Thomas Mabry em 18/12/2017

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Michael Teasdale em 18/12/2017

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 18/12/2017

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG em 18/12/2017

    1 páginasAD01

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 032034840016

    5 páginasMR05

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 032034840018

    5 páginasMR05

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 03/10/2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account 27/09/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    30 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 13/09/2017 com atualizações

    4 páginasCS01

    Todo o bem ou empresa foi libertado e já não faz parte da garantia 032034840017

    5 páginasMR05

    Quem são os diretores de RIBBON HOTELS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Secretário
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Diretor
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    LuxembourgGermanCompany Director204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Diretor
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritishDirector204008350001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secretário
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Secretário
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Secretário
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203652080001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secretário
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secretário
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    BritishCompany Secretary37564540001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Secretário
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Secretário
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Secretário
    Ten Bishops Square
    E1 6EG London
    Eighth Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro04131463
    125623230001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretário nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ALIBONE, Lee Russell
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    Diretor
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    BritishDirector53633890001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmericanInvestment Professional196342720001
    CARTWRIGHT, Stacey Lee
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    Diretor
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    BritishDirector37682070002
    CAU, Antoine Edmond Andre
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    Diretor
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    FrenchChief Executive59395250002
    COPELAND, Patrick Joseph
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    Diretor
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    United KingdomBritishDirector40574670003
    CROSTON, Francis John
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    Diretor
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    United KingdomBritishDirector65219360003
    DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    Diretor
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector100598030001
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Diretor
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutchAsset Manager169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Diretor
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishAccountant77133450001
    GRATTON, David Martin
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishFinancial Controller71901350002
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarianInvestment Professional193389430001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Diretor
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor241370450001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Diretor
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    BritishInternational Tax Manager78059700001
    MARTIN, Andrew David
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector52743800001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Diretor
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United StatesBanker112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Diretor
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant75569660002
    MITCHELL, Paul Raymond
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    Diretor
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    EnglandBritishDirector148147140001
    MORLEY, Ronald Martin
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    Diretor
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    UkBritishDirector517180003
    MORTIMER, David Grant
    8 Manor Park Avenue
    SP27 9AU Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Diretor
    8 Manor Park Avenue
    SP27 9AU Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director47770480001
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Diretor
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadianManaging Director62529820001
    PARROTT, Graham Joseph
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    Diretor
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    BritishCompany Director6741720003
    POSTER, Stephen Michael
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    Diretor
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    BritishDirector67532380001
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Diretor
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadianManaging Director85682450077

    Quem são as pessoas com controle significativo de RIBBON HOTELS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06/04/2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro04160938
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    RIBBON HOTELS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 08/12/2015
    Entregue em 11/12/2015
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Holiday inn glasgow airport, caledonian way west, abbotsinch, paisley t/no REN71989.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Pessoas com direito
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent)
    Transações
    • 11/12/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 18/12/2017Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 05/04/2018Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 03/12/2015
    Entregue em 09/12/2015
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transações
    • 09/12/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/09/2017Todo o imóvel ou empresa foi liberado e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 01/12/2015
    Entregue em 02/12/2015
    Pendente
    Breve descrição
    L/H holiday inn basildon cranes farm road basildon t/no.EX303185 and EX437596 for more details please refer to the instrument.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transações
    • 02/12/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 05/09/2017Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 18/12/2017Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 31/05/2013
    Entregue em 11/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    All and whole subjects k/a holiday inn glasgow airport caledonia way west abbotsinch paisley t/n REN71980. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag London Branch for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transações
    • 11/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 03/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 22/05/2013
    Entregue em 04/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag London Branch for Itself and as Security Trustee for the Common Secured Parties
    Transações
    • 04/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 03/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 22/05/2013
    Entregue em 03/06/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    F/H the bybrook tavern (public house) canterbury road ashford t/no K278847, l/h holiday inn cranes farm road basildon t/no’s EX303185 and EX437596, l/h basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409820 (ig lease), for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transações
    • 03/06/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 04/09/2014Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 04/11/2014Parte do imóvel ou empresa foi liberada da garantia (MR05)
    • 02/12/2014Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 07/04/2015Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 11/06/2015Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    • 03/12/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and
    Criado em 27/06/2005
    Entregue em 11/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All and whole the tenant's interest in the lease between corporation of the city of glasgow and royal hibernian hotel limited. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Trustee Company Limited Acting as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transações
    • 11/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 03/06/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and
    Criado em 20/06/2005
    Entregue em 11/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due by an obligor to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All and whole the tenant's interest in the lease between the corporation of the city of glasgow and airport services limited. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Trustee Company Limited Acting as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transações
    • 11/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 04/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Mortgage
    Criado em 20/06/2005
    Entregue em 28/06/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Breve descrição
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transações
    • 28/06/2005Registro de uma garantia (395)
    • 04/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 20/06/2005
    Entregue em 22/06/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transações
    • 22/06/2005Registro de uma garantia (395)
    • 18/04/2006Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 06/09/2006Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 04/06/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Second supplemantal trust deed
    Criado em 02/08/1996
    Adquirido em 05/09/1996
    Entregue em 19/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    Securing £200,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of granada group PLC, all further first mortgage debenture stock (together the "stock") and all other amounts payable by granada group PLC
    Breve descrição
    The various properties as listed on the form 400 inclusive of the kensington close, hotal, london and the excelsior, heathrow.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transações
    • 19/09/1996Registro de uma aquisição (400)
    • 05/04/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Second supplemental trust deed dated 2 august 1996 but having effect on 5 september 1996
    Criado em 02/08/1996
    Entregue em 19/09/1996
    Data do instrumento de cobertura 02/08/1996
    Totalmente satisfeita
    Pessoas com direito
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transações
    • 19/09/1996Registro de um encargo para garantir uma série de debêntures (397)
    • 18/01/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 31/01/1992
    Adquirido em 05/09/1996
    Entregue em 13/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,800,000
    Breve descrição
    All that property at st. Margarets roundabout, southampton road, titchfield, fareham, hampshire together with all hotel buildings thereon.
    Pessoas com direito
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Hotel Fund Limited)
    Transações
    • 13/09/1996Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 13/10/1989
    Adquirido em 05/09/1996
    Entregue em 13/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,400,000
    Breve descrição
    All that piece of land at aylesbury in the couity of buckingham having frontage to the london to birmingham trunk road (A41) (including southern boundary hedge) together with hotel buildings thereon.
    Pessoas com direito
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transações
    • 13/09/1996Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 08/03/1989
    Adquirido em 05/09/1996
    Entregue em 13/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,700,000
    Breve descrição
    All that land situate on the south side od castle street east of commercial road and to the north of railway dock in the city of kingston upon hull together with buildings thereon and k/a the post house hotel t/n HS148908.
    Pessoas com direito
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transações
    • 13/09/1996Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 31/10/1988
    Adquirido em 05/09/1996
    Entregue em 13/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,580,000
    Breve descrição
    All that land and buldings on the west side of the guildford and godalming by-pass guildford in the county of surrey together with all buildings thereon k/a the post house hotel guildford t/n SY546878.
    Pessoas com direito
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transações
    • 13/09/1996Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 13/10/1988
    Adquirido em 05/09/1996
    Entregue em 13/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,700,000
    Breve descrição
    All land and buildings fronting lonon road, maidstone,kenttogether with all buildings k/a the post house hotel maidstone t/n K99811.
    Pessoas com direito
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transações
    • 13/09/1996Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 12/06/1985
    Adquirido em 05/09/1996
    Entregue em 13/09/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £838,800
    Breve descrição
    The L.h parcels of land situate at impington in the county of cambridge together with hotel buildings thereon.
    Pessoas com direito
    • Cin Hotel Limited(Formerly Cin Post Houses Fund Limited)
    Transações
    • 13/09/1996Registro de uma aquisição (400)
    • 21/08/1997Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    RIBBON HOTELS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    30/11/2017Início da liquidação
    17/04/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0