RIBBON HOTELS LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | RIBBON HOTELS LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 03203484 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Sim |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de RIBBON HOTELS LIMITED?
- Hotéis e alojamentos semelhantes (55100) / Alojamento, restauração e similares
Onde fica RIBBON HOTELS LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de RIBBON HOTELS LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
LRG HOTELS LIMITED | 26/05/2005 | 26/05/2005 |
INTERCONTINENTAL HOTELS LIMITED | 16/04/2003 | 16/04/2003 |
SIX CONTINENTS HOTELS LIMITED | 16/07/2002 | 16/07/2002 |
POSTHOUSE HOTELS LIMITED | 06/11/1996 | 06/11/1996 |
POST HOUSES LIMITED | 19/07/1996 | 19/07/1996 |
865TH SHELF TRADING COMPANY LIMITED | 24/05/1996 | 24/05/1996 |
Quais são as últimas contas de RIBBON HOTELS LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2016 |
Quais são as últimas submissões para RIBBON HOTELS LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 17 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/11/2018 | 16 páginas | LIQ03 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Justin Bruce Robinson como diretor em 14/09/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Satisfação total da garantia 032034840018 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD03 | ||||||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 22/12/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaração de solvência | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Haysmacintyre Company Secretaries Limited em 18/12/2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Patrick Thomas Mabry em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Michael Teasdale em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG em 18/12/2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 032034840016 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 032034840018 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado do capital em 03/10/2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 30 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 13/09/2017 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado e já não faz parte da garantia 032034840017 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de RIBBON HOTELS LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
MABRY, Patrick Thomas | Diretor | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Luxembourg | German | Company Director | 204005420001 | ||||||||
TEASDALE, Simon Michael | Diretor | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | Director | 204008350001 | ||||||||
COMBEER, Jean Brenda | Secretário | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
ENGMANN, Catherine | Secretário | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
LOYNES, Paul | Secretário | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203652080001 | |||||||||||
MASON, Timothy Charles | Secretário | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||||||
TAUTZ, Helen Jane | Secretário | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | Company Secretary | 37564540001 | |||||||||
WILLIAMS, Alison | Secretário | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secretário | Ten Bishops Square E1 6EG London Eighth Floor United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
SISEC LIMITED | Secretário nomeado | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
ALIBONE, Lee Russell | Diretor | Darnley Lodge 68 Marsh Road HA5 5NQ Pinner Middlesex | British | Director | 53633890001 | |||||||||
BAKER, Skardon Francis | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | Investment Professional | 196342720001 | ||||||||
CARTWRIGHT, Stacey Lee | Diretor | 46 Chiddingstone Road SW6 3TG London | British | Director | 37682070002 | |||||||||
CAU, Antoine Edmond Andre | Diretor | 10a Durward House 31 Kensington Court S8 5BH London | French | Chief Executive | 59395250002 | |||||||||
COPELAND, Patrick Joseph | Diretor | 120 Hamilton Terrace NW8 9UT London | United Kingdom | British | Director | 40574670003 | ||||||||
CROSTON, Francis John | Diretor | 5 The Laurels Queenborough Lane CM77 7QD Braintree Essex | United Kingdom | British | Director | 65219360003 | ||||||||
DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Diretor | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | Director | 100598030001 | ||||||||
EKAS, Petra Cecilia Maria | Diretor | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | Asset Manager | 169731050002 | ||||||||
FISH, Andrew John | Diretor | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | Accountant | 77133450001 | ||||||||
GRATTON, David Martin | Diretor | Rosemead 9 Chiltern Hills Road HP9 1PJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Financial Controller | 71901350002 | |||||||||
KOLEV, Ivaylo | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | Investment Professional | 193389430001 | ||||||||
LOYNES, Paul | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 241370450001 | ||||||||
MACKENZIE, Lisa Marie | Diretor | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | International Tax Manager | 78059700001 | |||||||||
MARTIN, Andrew David | Diretor | 5 Dalkeith Road AL5 5PP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 52743800001 | ||||||||
MCCARTHY, John Patrick | Diretor | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | Banker | 112396050001 | |||||||||
MCEWAN, Allan Scott | Diretor | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 75569660002 | ||||||||
MITCHELL, Paul Raymond | Diretor | Waltons Farm Hollygreen Lane HP27 9PL Bledlow Bucks England | England | British | Director | 148147140001 | ||||||||
MORLEY, Ronald Martin | Diretor | 8 Pinewood Close SL0 0QT Iver Heath Buckinghamshire | Uk | British | Director | 517180003 | ||||||||
MORTIMER, David Grant | Diretor | 8 Manor Park Avenue SP27 9AU Princes Risborough Buckinghamshire | British | Finance Director | 47770480001 | |||||||||
NEWMAN, Mark | Diretor | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | Managing Director | 62529820001 | ||||||||
PARROTT, Graham Joseph | Diretor | Flat 1 27 Redington Road Hampstead NW3 7QY London | British | Company Director | 6741720003 | |||||||||
POSTER, Stephen Michael | Diretor | 46 Boileau Road W5 3AH London | British | Director | 67532380001 | |||||||||
PRINCE, Ryan David | Diretor | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | Managing Director | 85682450077 |
Quem são as pessoas com controle significativo de RIBBON HOTELS LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nas Cobalt No.2 Limited | 06/04/2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
|
RIBBON HOTELS LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Criado em 08/12/2015 Entregue em 11/12/2015 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Holiday inn glasgow airport, caledonian way west, abbotsinch, paisley t/no REN71989. Contém uma promessa negativa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A registered charge | Criado em 03/12/2015 Entregue em 09/12/2015 | Pendente | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A registered charge | Criado em 01/12/2015 Entregue em 02/12/2015 | Pendente | ||
Breve descrição L/H holiday inn basildon cranes farm road basildon t/no.EX303185 and EX437596 for more details please refer to the instrument. Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A registered charge | Criado em 31/05/2013 Entregue em 11/06/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição All and whole subjects k/a holiday inn glasgow airport caledonia way west abbotsinch paisley t/n REN71980. Notification of addition to or amendment of charge. Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A registered charge | Criado em 22/05/2013 Entregue em 04/06/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição Notification of addition to or amendment of charge. Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A registered charge | Criado em 22/05/2013 Entregue em 03/06/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição F/H the bybrook tavern (public house) canterbury road ashford t/no K278847, l/h holiday inn cranes farm road basildon t/no’s EX303185 and EX437596, l/h basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409820 (ig lease), for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge. Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and | Criado em 27/06/2005 Entregue em 11/07/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All and whole the tenant's interest in the lease between corporation of the city of glasgow and royal hibernian hotel limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and | Criado em 20/06/2005 Entregue em 11/07/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due by an obligor to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All and whole the tenant's interest in the lease between the corporation of the city of glasgow and airport services limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage | Criado em 20/06/2005 Entregue em 28/06/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descrição L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 20/06/2005 Entregue em 22/06/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Second supplemantal trust deed | Criado em 02/08/1996 Adquirido em 05/09/1996 Entregue em 19/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido Securing £200,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of granada group PLC, all further first mortgage debenture stock (together the "stock") and all other amounts payable by granada group PLC | |
Breve descrição The various properties as listed on the form 400 inclusive of the kensington close, hotal, london and the excelsior, heathrow.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Second supplemental trust deed dated 2 august 1996 but having effect on 5 september 1996 | Criado em 02/08/1996 Entregue em 19/09/1996 Data do instrumento de cobertura 02/08/1996 | Totalmente satisfeita | ||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 31/01/1992 Adquirido em 05/09/1996 Entregue em 13/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,800,000 | |
Breve descrição All that property at st. Margarets roundabout, southampton road, titchfield, fareham, hampshire together with all hotel buildings thereon. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 13/10/1989 Adquirido em 05/09/1996 Entregue em 13/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,400,000 | |
Breve descrição All that piece of land at aylesbury in the couity of buckingham having frontage to the london to birmingham trunk road (A41) (including southern boundary hedge) together with hotel buildings thereon. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 08/03/1989 Adquirido em 05/09/1996 Entregue em 13/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,700,000 | |
Breve descrição All that land situate on the south side od castle street east of commercial road and to the north of railway dock in the city of kingston upon hull together with buildings thereon and k/a the post house hotel t/n HS148908. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 31/10/1988 Adquirido em 05/09/1996 Entregue em 13/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,580,000 | |
Breve descrição All that land and buldings on the west side of the guildford and godalming by-pass guildford in the county of surrey together with all buildings thereon k/a the post house hotel guildford t/n SY546878. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 13/10/1988 Adquirido em 05/09/1996 Entregue em 13/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £1,700,000 | |
Breve descrição All land and buildings fronting lonon road, maidstone,kenttogether with all buildings k/a the post house hotel maidstone t/n K99811. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal charge | Criado em 12/06/1985 Adquirido em 05/09/1996 Entregue em 13/09/1996 | Totalmente satisfeita | Montante garantido £838,800 | |
Breve descrição The L.h parcels of land situate at impington in the county of cambridge together with hotel buildings thereon. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
RIBBON HOTELS LIMITED possui casos de insolvência?
Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0