WILLMOT PERTWEE LIMITED

WILLMOT PERTWEE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaWILLMOT PERTWEE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03206948
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    • Atividades de apoio à produção agrícola (01610) / Agricultura, silvicultura e pesca

    Onde fica WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CELANDOR LIMITED03/06/199603/06/1996

    Quais são as últimas contas de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/07/2021

    Quais são as últimas submissões para WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    2 páginasDS01

    Estado do capital em 18/02/2022

    • Capital: GBP 0.50
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 31/07/2021

    18 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/07/2020

    17 páginasAA

    Término da nomeação de Christopher Stephen Matthews como diretor em 27/02/2021

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/07/2019

    18 páginasAA

    Nomeação de Mr Neil Reid como diretor em 19/11/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Peter Michael Dunne como diretor em 19/11/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/07/2018

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mr James Marshall Rennie como diretor em 20/02/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Peter Dunne como diretor em 28/02/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Imelda Hurley como diretor em 28/02/2018

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/07/2017

    17 páginasAA

    Término da nomeação de Declan Patrick Giblin como diretor em 21/07/2017

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de David Stewart Downie como diretor em 24/07/2017

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 31/07/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Quem são os diretores de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    EVANS, Spencer Gareth
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    EnglandBritish227570820001
    HUGHES, Ronan Andrew
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandIrish164466890001
    REID, Neil
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    D24 Dcw0
    Ireland
    Diretor
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    D24 Dcw0
    Ireland
    IrelandIrish266176680001
    RENNIE, James Marshall
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United KingdomBritish245275770001
    BADBERG, Sue Ellen
    1245 North 13th Street
    68410 Nebraska City
    Nebraska
    Usa
    Secretário
    1245 North 13th Street
    68410 Nebraska City
    Nebraska
    Usa
    British47974150003
    BRENNAN, Thomas Patrick
    1 Penrwyn Court
    PE19 2SU St Neots
    Cambridgeshire
    Secretário
    1 Penrwyn Court
    PE19 2SU St Neots
    Cambridgeshire
    British202542640001
    MURRAY, David Souter
    .
    GL54 4LZ Cheltenham
    Andoversford
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secretário
    .
    GL54 4LZ Cheltenham
    Andoversford
    Gloucestershire
    United Kingdom
    164578240001
    RB SECRETARIAT LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Secretário nomeado
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006270001
    BOLDING, Jay Douglas
    3325 North 134 Circle
    Omaha
    Nebraska 68164
    Usa
    Diretor
    3325 North 134 Circle
    Omaha
    Nebraska 68164
    Usa
    American65252730002
    BROWN, Richard
    Manor Farmhouse
    Manor Farm, Eddlethorpe
    YO17 9QT Malton
    North Yorkshire
    Diretor
    Manor Farmhouse
    Manor Farm, Eddlethorpe
    YO17 9QT Malton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish111686890001
    CASEY, Walter
    414 Martin Drive North
    Bellevue
    68005 Nebraska
    Usa
    Diretor
    414 Martin Drive North
    Bellevue
    68005 Nebraska
    Usa
    Amercian50862220001
    DERBYSHIRE, Stephen
    The Gables
    Pump Lane, Fenton
    NG23 5DF Newark
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Gables
    Pump Lane, Fenton
    NG23 5DF Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish64532980001
    DIFONZO, Kenneth Wayne
    16646 Howard Circle
    Omaha
    68118 Nebraska
    Usa
    Diretor
    16646 Howard Circle
    Omaha
    68118 Nebraska
    Usa
    Us Citizen40453120001
    DOWNIE, David Stewart
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    EnglandBritish101857040001
    DUNNE, Peter Michael
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    Diretor
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    IrelandIrish296556910001
    FITZGERALD, Brendan
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    IrelandIrish142986030014
    GIBLIN, Declan Patrick
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandIrish33529010002
    HECKMAN, Gregory Allen
    6711 Davenport Street
    Omaha
    Nebraska 681342
    Usa
    Diretor
    6711 Davenport Street
    Omaha
    Nebraska 681342
    Usa
    American90638610004
    HURLEY, Imelda
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    Diretor
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    IrelandIrish190470420004
    JOHNSON, Owen Charles
    1117 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    Diretor
    1117 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    U S Citizen98512790001
    MATTHEWS, Christopher Stephen
    Dale Farm
    Collingham Road
    LN6 9JB Swinderby
    Lincolnshire
    Diretor
    Dale Farm
    Collingham Road
    LN6 9JB Swinderby
    Lincolnshire
    EnglandBritish104573600001
    MCKINNERNEY, Floyd
    9309 Fm 462 North
    Hondo
    Texas 78861
    Usa
    Diretor
    9309 Fm 462 North
    Hondo
    Texas 78861
    Usa
    American48604900002
    MESSEL, Scott Edward
    1124 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    Diretor
    1124 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    UsaU S Citizen98512890001
    MURRAY, David
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish25241430001
    O'DONNELL, James Patrick
    1126 S 181 Plaza
    Omaha
    Nebraska 68130
    U.S.A
    Diretor
    1126 S 181 Plaza
    Omaha
    Nebraska 68130
    U.S.A
    Us Citizen57520090002
    PRIESTLEY, Richard Paul
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United KingdomBritish138721210001
    ROBERTS, Jamie
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Diretor
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish176036360001
    SHARP, Barry John
    The Old Orchard
    Bekesbourne Lane Bekesbourne
    CT4 5DY Canterbury
    Kent
    Diretor
    The Old Orchard
    Bekesbourne Lane Bekesbourne
    CT4 5DY Canterbury
    Kent
    EnglandBritish35545820002
    THOMAS, Lawrence Bruce
    7813 Pierce
    Omaha 68124
    Nebraska
    United States Of America
    Diretor
    7813 Pierce
    Omaha 68124
    Nebraska
    United States Of America
    United States75675670003
    RB DIRECTORS ONE LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Diretor nomeado
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006260001
    RB DIRECTORS TWO LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Diretor nomeado
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006250001

    Quem são as pessoas com controle significativo de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Agrii
    England
    06/04/2016
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Agrii
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro05300865
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    WILLMOT PERTWEE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 18/04/2008
    Entregue em 29/04/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 29/04/2008Registro de uma garantia (395)
    • 22/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    All assets debenture
    Criado em 28/04/2005
    Entregue em 07/05/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 07/05/2005Registro de uma garantia (395)
    • 24/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 28/04/2005
    Entregue em 05/05/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a or being land and buildings on the east side of gorse lane harlaxton linciolnshire t/no LL59771 all book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 05/05/2005Registro de uma garantia (395)
    • 24/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 28/04/2005
    Entregue em 05/05/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a or being land and buildings on the west side of asperton road wigtoft lincolnshire t/no LL117979. All book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transações
    • 05/05/2005Registro de uma garantia (395)
    • 24/04/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0