CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED

CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03215059
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED?

    • construção de edifícios comerciais (41201) / Construção

    Onde fica CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Greenfield Business Park No2
    Greenfield
    CH8 7GJ Holywell Flintshire
    North Wales
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CENTURY HOMES TIMBER FRAMES LIMITED27/02/200327/02/2003
    ALPHA TIMBER FRAME LIMITED21/06/199621/06/1996

    Quais são as últimas contas de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2011

    Quais são as últimas submissões para CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração anual preparada até 30/11/2012 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/12/2012

    Estado do capital em 03/12/2012

    • Capital: GBP 118,750
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2011

    8 páginasAA

    Declaração anual preparada até 30/11/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2010

    8 páginasAA

    Término da nomeação de Dermot Mulvihill como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Geoff Doherty como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 30/11/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2009

    8 páginasAA

    Término da nomeação de Paul Mcdonald como diretor

    1 páginasTM01

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Declaração anual preparada até 30/11/2009 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Término da nomeação de Gilbert Mccarthy como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Brendan Feeney como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Dermot Mulvihill como diretor

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2008

    9 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    Contas preparadas até 31/12/2007

    12 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Quem são os diretores de CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KINGSPAN GROUP LIMITED
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    Secretário
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    107980110001
    DOHERTY, Geoff Patrick
    Somerton
    Castleknock Golf Club, Porterstown Road
    Castleknock
    11
    Dublin 15
    Ireland
    Diretor
    Somerton
    Castleknock Golf Club, Porterstown Road
    Castleknock
    11
    Dublin 15
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director161069960001
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    Secretário
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    BritishChartered Accountant Company D68232410001
    HALEY, Robert George
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    Secretário
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    BritishCompany Director49852280001
    KNIGHT, Amanda Jayne
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    Secretário
    Llanberis
    Monmouth Road
    NP15 2LA Raglan
    Monmouthshire
    British78119010001
    MCBRIDE, James William
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    Secretário
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    IrishTechnical Director84570680001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Secretário
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrishDirector145024250001
    PATTERSON, Margaret
    5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Secretário
    5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    British64805740001
    ROWLES, Paul
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    Secretário
    23 Hazel Close
    New Inn
    NP4 0RR Pontypool
    Torfaen
    British47041550002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FEENEY, Brendan
    86 The Grove
    Celbridge
    Kildare
    Ireland
    Diretor
    86 The Grove
    Celbridge
    Kildare
    Ireland
    IrelandIrishDirector197044280001
    FIGUEIRA, John Andrew
    Lutetia
    18 Friard Gate
    GU2 7PQ Guildford
    Surrey
    Diretor
    Lutetia
    18 Friard Gate
    GU2 7PQ Guildford
    Surrey
    EnglandBritishTechnical Director127913060002
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    Diretor
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    BritishChartered Accountant68232410001
    GREENSTREET, Simon David John
    Polly Cottage
    Southover Way Hunston
    PO20 6NY Chichester
    West Sussex
    Diretor
    Polly Cottage
    Southover Way Hunston
    PO20 6NY Chichester
    West Sussex
    BritishCompany Director47041540001
    HALEY, Robert George
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    Diretor
    4 Southwold Close
    Copperfields
    WR5 3RD Worcester
    BritishCompany Director49852280001
    KNIGHT, Colwyn Roy
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    Diretor
    The Mount
    Castle Road
    NP15 2JZ Raglan
    Monmouthshire
    WalesBritishCompany Director23297760001
    KNIGHT, Melville William
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    Diretor
    Wood Farm
    Gwehelog
    NP15 1RD Usk
    WalesBritishCompany Director23297750005
    MCBRIDE, James William
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    Diretor
    Ballymacforban
    IRISH Monaghan
    Ireland
    IrishTechnical Director84570680001
    MCCARTHY, Gilbert
    Forest Haven
    Cabra
    IRISH Kingscourt
    Co Cavan
    Ireland
    Diretor
    Forest Haven
    Cabra
    IRISH Kingscourt
    Co Cavan
    Ireland
    IrelandIrishDirector172436310001
    MCCAUGHEY, Gerald Vincent
    Lathlurcan
    IRISH Co. Monaghan
    Ireland
    Diretor
    Lathlurcan
    IRISH Co. Monaghan
    Ireland
    IrishManaging Director84914210002
    MCDONALD, Paul
    17 Cairnsfort
    Stepaside
    Dublin 18
    Ireland
    Diretor
    17 Cairnsfort
    Stepaside
    Dublin 18
    Ireland
    IrishMarketing Director84570330002
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Cloverhill
    Co Meath
    Ireland
    Diretor
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Cloverhill
    Co Meath
    Ireland
    IrelandIrishDirector145024250001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Diretor
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrelandIrishDirector145024250001
    MURTAGH, Brendan
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Diretor
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector30924190002
    MURTAGH, Eugene
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    Diretor
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishDirector16536550001
    MURTAGH, Gene
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    Diretor
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    IrelandIrishDirector66920570002
    PATTERSON, Gordon
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Diretor
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern IrelandBritishCompany Director65359330001
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Diretor
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishCompany Director65359270002
    WHITTLE, Nicholas
    Leander Avenue Road
    GU6 7LL Cranleigh
    Surrey
    Diretor
    Leander Avenue Road
    GU6 7LL Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director49770220002

    CENTURY HOMES TIMBER FRAME LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 09/09/2005
    Entregue em 16/09/2005
    Pendente
    Montante garantido
    £8255 due or to become due from the company to
    Breve descrição
    £8255.
    Pessoas com direito
    • Mary Louise Seldon
    Transações
    • 16/09/2005Registro de uma garantia (395)
    Mortgage debenture
    Criado em 30/03/2001
    Entregue em 19/04/2001
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 19/04/2001Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 30/03/2001
    Entregue em 14/04/2001
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 30 tafarnaubach industrial estate tredegar monmouthshire WA799148. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 14/04/2001Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 30/03/2001
    Entregue em 07/04/2001
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a unit 29 tafarnaubach industrial estate tredgar monmouthshire t/no: WA829943. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 07/04/2001Registro de uma garantia (395)
    Legal mortgage
    Criado em 30/07/1999
    Entregue em 19/08/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 29 tafarnaubach industrial estate tredegar.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 19/08/1999Registro de uma garantia (395)
    • 24/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 24/06/1999
    Entregue em 02/07/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 02/07/1999Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Criado em 21/04/1997
    Entregue em 26/04/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease
    Breve descrição
    The deposit of £8,255.
    Pessoas com direito
    • Mary Louise Foulston
    Transações
    • 26/04/1997Registro de uma garantia (395)
    • 24/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage
    Criado em 26/07/1996
    Entregue em 13/08/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Unit 30 tafarnaubach industrial estate tredegar benefit of all rights licences contracts deeds assigns goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 13/08/1996Registro de uma garantia (395)
    • 24/09/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 25/07/1996
    Entregue em 27/07/1996
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 27/07/1996Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0