PHIP CH LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPHIP CH LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03217536
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PHIP CH LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica PHIP CH LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PHIP CH LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CATHEDRAL HEALTHCARE LIMITED11/05/200411/05/2004
    MOUNT ANVIL HEALTHCARE LIMITED12/05/199912/05/1999
    PRIMARY PARTNERSHIPS LIMITED01/05/199801/05/1998
    ANVIL LONDON LIMITED27/06/199627/06/1996

    Quais são as últimas contas de PHIP CH LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para PHIP CH LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    5 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 10/07/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Satisfação total da garantia 8

    4 páginasMR04

    Nomeação de Mr David Christopher Austin como diretor em 01/04/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Timothy David Walker Arnott como diretor em 01/04/2017

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Richard Howell como diretor em 01/04/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Philip John Holland como diretor em 01/04/2017

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    5 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 10/07/2016 com atualizações

    6 páginasCS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Philip John Holland em 08/07/2016

    2 páginasCH01

    Declaração anual preparada até 10/07/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital10/07/2015

    Estado do capital em 10/07/2015

    • Capital: GBP 1,333
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    13 páginasAA

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 02/07/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital30/07/2014

    Estado do capital em 30/07/2014

    • Capital: GBP 1,333
    SH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Timothy David Walker Arnott em 01/05/2014

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Timothy David Walker Arnott em 22/07/2014

    2 páginasCH01

    Nomeação de Nexus Management Services Limited como secretário

    3 páginasAP04

    Endereço do domicílio registado alterado de * Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* em 07/05/2014

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Margaret Vaughan como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de J O Hambro Capital Management Limited como secretário

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 25/06/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/07/2013

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 22/07/2013

    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2012

    5 páginasAA

    Quem são os diretores de PHIP CH LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Secretário
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro4187765
    57253330002
    AUSTIN, David Christopher
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Diretor
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish131339590001
    HOWELL, Richard
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Diretor
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Diretor
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish35560380005
    DEAMER, Kenneth
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    Secretário
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    British8521670002
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secretário
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Irish47179960002
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Secretário
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    STEVENS, Philip Martin
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    Secretário
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    British102528350001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretário nomeado
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Secretário
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2176004
    117915530003
    BENNETT, Barry John
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Diretor
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomIrish14707370002
    BORER, Derek
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    Diretor
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    British60451400001
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Diretor
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish53684400001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Diretor
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish163838050001
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Diretor
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomIrish47179960002
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    Diretor
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritish141827450001
    NEWMAN, Victor Edward
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    Diretor
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    British23635170001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Diretor
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish81998190003
    UPTON, Richard
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    Diretor
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    EnglandBritish204950320001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Diretor
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish123167120001
    WALKER ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Diretor
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish61889360004
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Diretor nomeado
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Diretor nomeado
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Quem são as pessoas com controle significativo de PHIP CH LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Primary Health Properties Plc
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    01/06/2016
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    Não
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroEngland And Wales
    Número de registro3033634
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

    PHIP CH LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 02/04/2012
    Entregue em 04/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 04/04/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 13/04/2017Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 17/03/2008
    Entregue em 28/03/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transações
    • 28/03/2008Registro de uma garantia (395)
    • 02/04/2008
    • 16/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Criado em 01/06/2007
    Entregue em 14/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transações
    • 14/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 01/06/2007
    Entregue em 14/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 14/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 16/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 13/06/2006
    Entregue em 15/06/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 15/06/2006Registro de uma garantia (395)
    • 10/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 09/01/2006
    Entregue em 17/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 17/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 10/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 09/01/2006
    Entregue em 11/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 11/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 10/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 26/11/2004
    Entregue em 02/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 02/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 10/01/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0