MICROPONENTS (PLATES) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | MICROPONENTS (PLATES) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03218207 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 11 Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| ODDJOB QUEENSVILLE 1 LIMITED | 28/06/1996 | 28/06/1996 |
Quais são as últimas contas de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2016 |
Quais são as últimas submissões para MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital em 10/09/2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/08/2018 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 12 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de Mr Michael Taylor como diretor em 21/04/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Ian Robert, Mark Mcmurray como diretor em 21/04/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Marina Louise Thomas como diretor em 21/04/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Ian Keith Pargeter como diretor em 21/04/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Derek John O'neill como diretor em 21/04/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Simon Robert Grant como secretário em 21/04/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Atlantic House Aviation Park West, Bournemouth International Airport Christchurch Dorset BH23 6EW para 11 Vantage Way Erdington Birmingham B24 9GZ em 23/04/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/08/2017 com atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Simon Robert Grant como secretário em 28/10/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Marina Thomas como secretário em 28/10/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/08/2016 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações | 3 páginas | SH10 | ||||||||||
Alteração do nome ou designação da classe de ações | 2 páginas | SH08 | ||||||||||
Quem são os diretores de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMURRAY, Ian Robert, Mark | Diretor | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 153191380001 | |||||
| TAYLOR, Michael | Diretor | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 245595040001 | |||||
| CLOWES, Stephen | Secretário | 24 Willesley Gardens LE65 2QF Ashby De La Zouch Leicestershire | British | 1764410001 | ||||||
| GRANT, Simon Robert | Secretário | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | 217318510001 | |||||||
| HINCHLEY, Karen Jane | Secretário | 66 Stone Road ST16 2RS Stafford | British | 50580120001 | ||||||
| KERIN, John Brendan | Secretário | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | British | 56704130004 | ||||||
| THOMAS, Marina | Secretário | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | British | 170765880001 | ||||||
| CLOWES, Stephen | Diretor | 24 Willesley Gardens LE65 2QF Ashby De La Zouch Leicestershire | England | British | 1764410001 | |||||
| GOLESTANI, Kian | Diretor | 2 Hawkesmoor Drive WS14 9YH Lichfield Staffordshire | British | 46764350001 | ||||||
| GREEN, Philip Ernest | Diretor | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 5495960002 | |||||
| HUTCHISON MOSS, James | Diretor | 455 Lichfield Road B74 4DJ Four Oaks Sutton Coldfield | British | 86536870001 | ||||||
| KERIN, John Brendan | Diretor | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | England | British | 56704130004 | |||||
| MARRETT, Anthony Rex | Diretor | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | England | British | 68981240003 | |||||
| MARRETT, Nicola Kathryn | Diretor | 17 Bishops Road B73 6HX Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 86353140001 | |||||
| MARRETT, Norman Rex | Diretor | Joberns Cottage Little Hay Lane WS14 0QD Lichfield Staffordshire | British | 1764420002 | ||||||
| MARRETT, Zoe Louise | Diretor | 8 Woodside Road HP9 1JG Beaconsfield Buckinghamshire | British | 86353350001 | ||||||
| O'NEILL, Derek John | Diretor | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | United Kingdom | British | 87573010001 | |||||
| PARGETER, Ian Keith | Diretor | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 123123230001 | |||||
| THOMAS, Marina Louise | Diretor | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 183635400001 | |||||
| TWIGGER, Terence | Diretor | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 45754710002 | |||||
| YOUNG, Mark Lees | Diretor | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 85330350002 | |||||
| YOUNG, Stephen Gareth | Diretor | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | United Kingdom | British | 21273730002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotomechanix Limited | 06/04/2016 | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
MICROPONENTS (PLATES) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Criado em 01/11/2003 Entregue em 05/11/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| All assets debenture deed | Criado em 10/12/2002 Entregue em 18/12/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 05/08/1998 Entregue em 11/08/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Fixed charge | Criado em 10/10/1997 Entregue em 16/10/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição 1 x new atotech pre clean machine ref. 8609-005 serial no. 070-5462. 1 x new atotech developer ref. 8609-002, serial no. 070-5459. 1 x new atotech stripper ref. 8609-004, serial no. 070-5461.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0