PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03238697 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
- desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
Onde fica PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 8 Cromwell Place SW7 2JN London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| PROPERTY VISION LIMITED | 10/01/1997 | 10/01/1997 |
| JAMBOREE LEISURE LIMITED | 16/08/1996 | 16/08/1996 |
Quais são as últimas contas de PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/03/2026 |
| Próximas contas vencem em | 31/12/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2025 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 15/08/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 29/08/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 15/08/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaração de confirmação apresentada em 15/08/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2025 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/08/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2024 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/08/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2023 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 16/08/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2022 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 16/08/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2021 | 7 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 16/08/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2020 | 7 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Robert Fanshawe como diretor em 23/04/2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Gulnara Long como diretor em 23/04/2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 16/08/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 16/08/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2018 | 7 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Peter Thomas Watts Mackie como diretor em 31/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Nicholas Wellesley De Courcy Ashe como diretor em 01/01/2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 16/08/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2017 | 7 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Richard Alexander John Marsh como diretor em 20/07/2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Término da nomeação de Charles Vincent Ellingworth como diretor em 20/07/2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 16/08/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||
Quem são os diretores de PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANSHAWE, Robert Leighton | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 England | United Kingdom | British | 269724990001 | |||||
| HARVEY, Philip Gerard | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 136453380003 | |||||
| BLACK, Nicola Suzanne | Secretário | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
| ELLINGWORTH, Charles Vincent | Secretário | New Park Farm Bratton Seymour BA9 8BX Wincanton Somerset | British | 51312610003 | ||||||
| HARVEY, Peter James | Secretário | 82 Frankfurt Road SE24 9NY London | Other | 67026460002 | ||||||
| JENKINSON, Louisa Jane | Secretário | Lindenwood Malacca Farm GU4 7UG West Clandon Surrey | British | 106060330003 | ||||||
| LYON, Karen | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 159996360001 | |||||||
| MCKENZIE, John Hume | Secretário | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Secretário | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 147957560001 | |||||||
| OWEN, Stephen | Secretário | Clayton Croft Road Wilmington DA2 7AU Kent 11 United Kingdom | 157126400001 | |||||||
| JPCORS LIMITED | Secretário nomeado | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001430001 | |||||||
| ALLEN, Christopher David | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 152566730001 | |||||
| ASHE, Nicholas Wellesley De Courcy | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | England | British | 51430490001 | |||||
| BALDOCK, John Stuart Saint Clair | Diretor | Rue Adolphe De Rothschild 06000 Nice 2 France | British | 110270390003 | ||||||
| BLINOFF, Lea | Diretor | Claridge House 32 Davies Street W1K 4ND London | England | British | 107556010001 | |||||
| BRADSTOCK, Rupert John | Diretor | The Old Rectory West Woodhay RG20 0BL Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 56332430001 | |||||
| COOK, Mary Elizabeth | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | British | 53057280002 | ||||||
| ELLINGWORTH, Charles Vincent | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | England | British | 51312610003 | |||||
| GEDDES, The Hon James George Neil | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | British | 124967990001 | ||||||
| GETHING, William James Rufus | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 175547400001 | |||||
| GREGSON, Marcus John | Diretor | Boarded Barn House Copford CO6 1DP Colchester Essex | England | British | 17279270001 | |||||
| HUDSON, Thomas Gordon | Diretor | Black And White Farmhouse Hollington RG20 9XN Newbury | United Kingdom | British | 142402530001 | |||||
| LEATHAM, Richard | Diretor | Shilton Manor Shilton OX18 4AS Burford Oxfordshire | British | 93175970002 | ||||||
| LONG, Gulnara | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 161584690001 | |||||
| MACKIE, Peter Thomas Watts | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 49882150002 | |||||
| MARSH, Richard Alexander John | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 161584600001 | |||||
| MCCOMBE, Mark Seumas | Diretor | Laleham Golf Club Road GU22 OLU Woking | British | 109350700001 | ||||||
| PARKINSON, Mark Derek | Diretor | 2 Harpsden Way RG9 1NL Henley-On-Thames Oxfordshire | England | British | 142402520001 | |||||
| PATERSON, Guy Duncan Cleland | Diretor | 17 Basil Mansions Basil Street SW3 1AP London | United Kingdom | British | 37960380004 | |||||
| SHARPLES, Richard Christopher | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 161584660001 | |||||
| SHEEHAN, Declan Kevin | Diretor | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 121326260003 | |||||
| SUGDEN, Edward Peter | Diretor | Cromwell Place SW7 2JN London 8 United Kingdom | England | British | 80113400001 | |||||
| JPCORD LIMITED | Diretor nomeado | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001420001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de PROPERTY VISION CROMWELL PLACE LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pv Acquisitions Limited | 06/04/2016 | Cromwell Place SW7 2JN London 8 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0