ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED

ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaABBEY PARK HOSPITAL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03279316
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1st Floor 30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    INHOCO 570 LIMITED15/11/199615/11/1996

    Quais são as últimas contas de ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2018

    Quais são as últimas submissões para ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Endereço do domicílio registado alterado de Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd para 1st Floor 30 Cannon Street London EC4M 6YN em 30/05/2019

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2018

    4 páginasAA

    Término da nomeação de Catherine Mary Jane Vickery como secretário em 30/11/2018

    1 páginasTM02

    Detalhes do diretor alterados para Dr Karen Anita Prins em 09/11/2018

    2 páginasCH01

    Término da nomeação de Catherine Mary Jane Vickery como diretor em 30/11/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 15/11/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/09/2017 para 31/03/2018

    1 páginasAA01

    Declaração de confirmação apresentada em 15/11/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Dr Karen Anita Prins como diretor em 01/10/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Jill Margaret Watts como diretor em 30/09/2017

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2016

    4 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 15/11/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2015

    4 páginasAA

    Declaração anual preparada até 15/11/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital16/12/2015

    Estado do capital em 16/12/2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomeação de Henry Jonathan Davies como diretor em 01/09/2015

    2 páginasAP01

    Nomeação de Ms Catherine Mary Jane Vickery como diretor em 01/05/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Craig Barry Lovelace como diretor em 30/04/2015

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2014

    4 páginasAA

    Nomeação de Jill Margaret Watts como diretor em 17/11/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Stephen John Collier como diretor em 16/11/2014

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 15/11/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital24/12/2014

    Estado do capital em 24/12/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/09/2013

    4 páginasAA

    Quem são os diretores de ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DAVIES, Henry Jonathan
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Diretor
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandBritishFinance Director201206200001
    PRINS, Karen Anita, Dr
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    Diretor
    30 Cannon Street
    EC4M 6YN London
    1st Floor
    England
    EnglandSouth AfricanChief Executive Officer238969330004
    DAY, Jonathan
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    Secretário
    19 Kenwood Road
    Highgate
    N6 4EA London
    BritishSolicitor122061300001
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Secretário
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    British66535330002
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Secretário
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    157319350001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretário nomeado
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    AINLEY, Harvey Bertenshaw
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Priory Road
    SL5 8EB Ascot
    Orchard House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant134262810002
    BUCKLEY, Fiona Marie
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    Diretor
    Browning House
    14 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director61688100004
    COLLIER, Stephen John
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Diretor
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector18350160001
    HEMMING, Eric Rodney
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Diretor
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    BritishOperations Director84030950001
    ISHAK HANNA, Magdy Adib, Dr
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    Diretor
    Eliot House
    40 Bishops Avenue Hampstead
    N2 0BA London
    EnglandBritishDirector76628190003
    LOVELACE, Craig Barry
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    Diretor
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant198852370001
    RAMSAY, James
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    Diretor
    The Old Post Office
    Village Road Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    BritishDirector40105120004
    RICHARDSON, Ian Ashley
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    Diretor
    Monkswell
    The Ridgeway
    EN6 4BH Northaw
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector66535330002
    ROBERTSON, Nigel Mark Inches
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    Diretor
    Sopworth
    SN14 6PT Chippenham
    Wookeys Barn
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector97170790002
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Diretor
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritishCompany Director641150001
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Diretor
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    United KingdomBritishGeneral Counsel & Company Secretary102009810003
    WATTS, Jill Margaret
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    Diretor
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    EnglandBritishGroup Chief Executive187252950001
    WIELAND, Phil
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    Diretor
    Thameside Centre
    Kew Bridge Road
    TW8 0HF Brentford
    4
    Middlesex
    United KingdomBritishFinance Director119448000002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Diretor nomeado
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Abbey Hospitals (Property) Limited
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    06/04/2016
    3 Paris Garden
    Southwark
    SE1 8ND London
    Bmi Healthcare House
    England
    Não
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroRegistrar Of Companies For England And Wales
    Número de registro03279311
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    ABBEY PARK HOSPITAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 14/04/2005
    Entregue em 29/04/2005
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ) as Security Trustee for the Secured Parties)(In Such Capacity the "Security Trustee")
    Transações
    • 29/04/2005Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 17/06/2002
    Entregue em 05/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 05/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 05/05/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 17/06/2002
    Entregue em 27/06/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that leasehold property known as land lying to the south of dalton lane barrow-in-furness LA14 4LF t/n CU88004. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 27/06/2002Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 22/01/2002
    Entregue em 01/02/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The original securities; all rights moneys (including without limitation dividends) and property whatsoever which may from time to time at any time be derived from accrue on or be offered in respect of the original securities,. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transações
    • 01/02/2002Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed to a legal charge dated 7TH march 1997
    Criado em 25/09/1998
    Entregue em 30/09/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in relation to the company in a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997 and made between inhoco 588 limited,abbey hospitals limited,inhoco 575 limited,the company and hsbc equity limited,as amended by a supplemental deed to the composite guarantee and debenture dated 25TH september 1998 (as defined)
    Breve descrição
    L/Hold property at barrow,cumbria; t/no cu 88004.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Equity Limited,as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transações
    • 30/09/1998Registro de uma garantia (395)
    • 23/01/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 7TH march 1997
    Criado em 25/09/1998
    Entregue em 30/09/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the loan notes (as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Equity Limited,as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transações
    • 30/09/1998Registro de uma garantia (395)
    • 23/01/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 07/03/1997
    Entregue em 14/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited or any group company as defined to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 05/02/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 07/03/1997
    Entregue em 14/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formally known as inhoco 570 limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All that l/h property k/a abbey park hospital,dalton lane,barrow in furness,cumbria.t/no.CU88004.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 19/06/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 07/03/1997
    Entregue em 11/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the loan notes and this charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transações
    • 11/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 23/01/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 07/03/1997
    Entregue em 11/03/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a composite guarantee and debenture of even date and this charge
    Breve descrição
    The underlease in the property k/a abbey park hospital dalton lane barrow cumbria t/no CU88004.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transações
    • 11/03/1997Registro de uma garantia (395)
    • 23/01/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0