SIGNS AND LABELS LIMITED

SIGNS AND LABELS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSIGNS AND LABELS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03318384
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SIGNS AND LABELS LIMITED?

    • (7415) /

    Onde fica SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Douglas Bruce House
    Corrie Way
    SK6 2RR Bredbury Park Industrial Estate
    Bredbury Stockport
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SIGNS & LABELS GROUP LIMITED26/03/199826/03/1998
    MARPLACE (NUMBER 405) LIMITED14/02/199714/02/1997

    Quais são as últimas contas de SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/07/2006

    Quais são as últimas submissões para SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:sos cert release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:Form 4.40 g g Bates ceasing to act
    1 páginasLIQ MISC

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    3 páginas4.71

    Despacho judicial de insolvência

    Court order INSOLVENCY:Replacement of Liquidator p j Windatt Replaces gg Bates 15/12/2009
    13 páginasLIQ MISC OC

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 22/10/2009

    5 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 22/04/2009

    5 páginas4.68

    Declaração de solvência

    9 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 23/04/2008

    LRESSP

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    Contas anuais preparadas até 31/07/2006

    21 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas88(2)R

    legacy

    2 páginas88(2)R

    legacy

    9 páginas363s

    Contas anuais preparadas até 31/07/2005

    23 páginasAA

    legacy

    1 páginas244

    legacy

    9 páginas363s

    Resoluções

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Conv shares 27/06/05
    RES13

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Contas consolidadas preparadas até 04/12/2004

    27 páginasAA

    Quem são os diretores de SIGNS AND LABELS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    JACKSON, John Paul
    4 Knightwood Glade
    Chandlers Ford
    SO53 4JA Eastleigh
    Hampshire
    Secretário
    4 Knightwood Glade
    Chandlers Ford
    SO53 4JA Eastleigh
    Hampshire
    British122350180001
    FELMER, Thomas James
    Hilly Lane
    Saukville
    8821
    Wisconsine
    United States
    Diretor
    Hilly Lane
    Saukville
    8821
    Wisconsine
    United States
    United States Of AmericaAmerican128854080001
    JAEHNERT, Frank Michael
    W68n1068 Kensington Avenue
    53012 Cedarburg
    Wisconsin
    Usa
    Diretor
    W68n1068 Kensington Avenue
    53012 Cedarburg
    Wisconsin
    Usa
    United States Of AmericaUsa68305240001
    SEPHTON, Peter Charles
    The Coach House
    Severnstoke Bank
    WR8 9JG Severnstoke
    Worcestershire
    Diretor
    The Coach House
    Severnstoke Bank
    WR8 9JG Severnstoke
    Worcestershire
    United KingdomBritish59319040003
    WALSHAM, Andrew Stuart
    15 Elm Road
    SN7 7EJ Faringdon
    Oxfordshire
    Diretor
    15 Elm Road
    SN7 7EJ Faringdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish33682210002
    BRANDWOOD, Christopher Mark
    Oak House Oak Road
    Mottram St Andrew
    SK10 4RA Macclesfield
    Cheshire
    Secretário
    Oak House Oak Road
    Mottram St Andrew
    SK10 4RA Macclesfield
    Cheshire
    British46508870001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Secretário
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    ASHLEY, Desmond Owen
    Holly Barn Holly Tree Walk
    Claybrooke Magna
    LE17 5DZ Lutterworth
    Leicestershire
    Diretor
    Holly Barn Holly Tree Walk
    Claybrooke Magna
    LE17 5DZ Lutterworth
    Leicestershire
    EnglandUnited Kingdom53386540002
    FITZGERALD, David Sean
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    Diretor
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    British61196400001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Diretor
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    HYAMS, Anthony Michael
    8 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    8 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    British56167340004
    MACDONALD, Iain Archibald
    7 Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    Diretor
    7 Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    ScotlandBritish3614100004
    MATHIESON, David
    10920 North Elizabeth Court
    Mequon
    Wisconsin 53097
    Usa
    Diretor
    10920 North Elizabeth Court
    Mequon
    Wisconsin 53097
    Usa
    British106586110001
    PADBERG, Mark Walter
    Thatchways
    Knobfield
    RH5 6RJ Abinger Hamer
    Surrey
    Diretor
    Thatchways
    Knobfield
    RH5 6RJ Abinger Hamer
    Surrey
    British89261420001
    ROCHE, Susan Louise
    Rose Farm
    Astley Moss
    M29 7LX Manchester
    Diretor
    Rose Farm
    Astley Moss
    M29 7LX Manchester
    Usa96243330001
    SCHOLES, Jeremy Hacking
    11 Gleneagles Drive
    Brockhall Village
    BB6 8BF Old Langho
    Lancashire
    Diretor
    11 Gleneagles Drive
    Brockhall Village
    BB6 8BF Old Langho
    Lancashire
    EnglandBritish108377220001
    STOREY, Richard George
    49 Kennerley Road
    SK2 6EU Stockport
    Cheshire
    Diretor
    49 Kennerley Road
    SK2 6EU Stockport
    Cheshire
    British11628330002

    SIGNS AND LABELS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Fixed and floating charge
    Criado em 08/12/2003
    Entregue em 09/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as signs and labels group limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 09/12/2003Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of life policy
    Criado em 07/10/2002
    Adquirido em 28/11/2003
    Entregue em 22/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Policy number jlt 18433 dated 8 may 2002 for £250,000 over the life of maria gabrielle higham. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/12/2003Registro de uma aquisição (400)
    • 13/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 10/05/2002
    Adquirido em 28/11/2003
    Entregue em 22/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 22/12/2003Registro de uma aquisição (400)
    • 13/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Assignment of life policy
    Criado em 21/10/1997
    Adquirido em 28/11/2003
    Entregue em 22/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Policy number RNF000401 52A with sun alliance and london insurance company limited in the life of richard storey. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/12/2003Registro de uma aquisição (400)
    • 13/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 10/07/1997
    Adquirido em 26/11/2003
    Entregue em 22/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/12/2003Registro de uma aquisição (400)
    • 13/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 10/07/1997
    Entregue em 16/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 16/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    SIGNS AND LABELS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    26/04/2010Data de dissolução
    23/04/2008Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Peter John Windatt
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    Profissional
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    Gavin Geoffrey Bates
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    Profissional
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0