CSC (HOLDINGS) LIMITED

CSC (HOLDINGS) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCSC (HOLDINGS) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03330075
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CSC (HOLDINGS) LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica CSC (HOLDINGS) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Trimble House Gelderd Road, Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CSC (HOLDINGS) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    IMCO (1297) LIMITED07/03/199707/03/1997

    Quais são as últimas contas de CSC (HOLDINGS) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2020

    Quais são as últimas submissões para CSC (HOLDINGS) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Estado do capital em 21/11/2022

    • Capital: GBP 0.10
    5 páginasSH19

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share premium account & capital redemption reserve 17/11/2022
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Declaração de confirmação apresentada em 14/01/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2020

    13 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/01/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2019

    6 páginasAA

    Nomeação de Julie Shepard como diretor em 01/10/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de John Peter Schreiber como diretor em 01/10/2020

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 14/01/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2018

    10 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 14/01/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma pequena empresa preparadas até 31/12/2017

    11 páginasAA

    Nomeação de Mr Algirdas Paul Rimas como diretor em 29/03/2018

    2 páginasAP01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Director appointed 29/03/2018
    RES13

    Nomeação de Mr John Peter Schreiber como diretor em 29/03/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Steven Walter Berglund como diretor em 01/04/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de John Ernest Huey Iii como diretor em 01/04/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 19/01/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    11 páginasAA

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Quem são os diretores de CSC (HOLDINGS) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    KIRKLAND, James Anthony, Vice President
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    Diretor
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    United StatesAmericanVp, General Counsel And Assistant Secretary183093010001
    RIMAS, Algirdas Paul
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    Diretor
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    United StatesAmericanDeputy General Counsel246182140001
    SHEPARD, Julie
    Gelderd Road, Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House
    Diretor
    Gelderd Road, Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House
    United StatesAmericanPrincipal Accounting Officer275379790001
    BELLWOOD, Simon Mark
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant14419800001
    DOBSON, Benjamin Richard Palin
    Buckley House
    Stanbury
    BD22 0HL Keighley
    West Yorkshire
    Secretário
    Buckley House
    Stanbury
    BD22 0HL Keighley
    West Yorkshire
    BritishDirector55189300001
    FEARNLEY, James Robert
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    Secretário
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant3798850001
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Secretário nomeado
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British900006640001
    BELLWOOD, Simon Mark
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant14419800002
    BERGLUND, Steven Walter
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    Diretor
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    United StatesAmericanPresident/Ceo183093300001
    BEVERIDGE, Andrew John
    47 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    West Yorkshire
    Diretor
    47 Effingham Road
    Harden
    BD16 1LQ Bingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director4387710002
    DOBSON, Benjamin Richard Palin
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector55189300002
    FEARNLEY, James Robert
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    Diretor
    The Moorings Waterside Walk
    Wood Lane
    WF14 0EB Mirfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant3798850001
    GEORGE, Christopher Robert
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector55189360002
    HARRISON, Andrew Nigel
    54 Conduit Road
    Sheffield
    South Yorkshire
    Diretor nomeado
    54 Conduit Road
    Sheffield
    South Yorkshire
    British900006650001
    HUEY III, John Ernest
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    Diretor
    Stewart Drive
    94085 Sunnyvale
    935
    Ca
    United States
    United StatesAmericanTreasurer183093060001
    ROBERTS, Mark Andrew
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    New Street
    Pudsey
    LS28 8AQ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales Director43094590003
    SCHREIBER, John Peter
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    Diretor
    Stewart Drive
    Sunnyvale
    935
    California
    Usa
    United StatesAmericanVice President Global Tax245661570001

    Quem são as pessoas com controle significativo de CSC (HOLDINGS) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House Gelderd Road
    United Kingdom
    06/04/2016
    Gildersome
    Morley
    LS27 7JP Leeds
    Trimble House Gelderd Road
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridade legalUnited Kingdom
    Local de registroCompanies House
    Número de registro4660899
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    CSC (HOLDINGS) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 23/01/2008
    Entregue em 30/01/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Clydesdale Bank PLC
    Transações
    • 30/01/2008Registro de uma garantia (395)
    • 25/11/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 28/03/2003
    Entregue em 11/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of legal mortgage all f/h and l/h property now vested in the company together with all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery from time to time on that property. By way of fixed charge all plant, machinery, vehicles, computers, all the goodwill and uncalled capital, all intellectual property rights. By way of floating charge all the company's present and future undertaking and assets whatever and wherever including all other property and assets not effectively charged by way of legal mortgage or fixed charge under the clauses above.
    Pessoas com direito
    • Andrew John Beveridge
    Transações
    • 11/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 11/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 28/03/2003
    Entregue em 04/04/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/04/2003Registro de uma garantia (395)
    • 11/01/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 10/07/1997
    Entregue em 25/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as imco (1297) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 25/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 09/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 10/07/1997
    Entregue em 22/07/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £600,000 guaranteed secure loan notes 1992-2002 and all sums owing thereunder due or to become due from the company formerly known as imco (1297) limited to robert edward yeadon and anita winifred yeadon in their personal capacities and also as trustees of computer services consultants (UK) limited directors pension fund
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Robert Edward Yeadon
    • Anita Winifred Yeadon
    Transações
    • 22/07/1997Registro de uma garantia (395)
    • 09/04/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0