IMCO RECONOMY 5 LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | IMCO RECONOMY 5 LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03347372 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
- coleta de resíduos não perigosos (38110) / Captação, tratamento e distribuição de água; gestão de resíduos; atividades de descontaminação e recuperação
Onde fica IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| SKIPS@HOME LIMITED | 18/04/2007 | 18/04/2007 |
| WELLS FARGO SKIPS LIMITED | 08/04/1997 | 08/04/1997 |
Quais são as últimas contas de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2016 |
Quais são as últimas submissões para IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de alteração do nome" | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 08/04/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 08/04/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Renúncia do auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL para Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD em 26/07/2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de Mr John Sullivan como secretário em 21/07/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Richard Llewelyn Milnes-James como diretor em 21/07/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Charles Nicholas Pollard como diretor em 21/07/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Alistair Myrie Holl como diretor em 21/07/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Caroline Elizabeth Allen como secretário em 21/07/2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr John Terence Sullivan como diretor em 21/07/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Paul Cox como diretor em 21/07/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 033473720005 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 5 páginas | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Ms Caroline Elizabeth Allen como secretário em 11/04/2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Sophie Catherine Jane Reed como secretário em 01/04/2016 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 08/04/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Peter Anton Gerstrom como diretor em 01/12/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Charles Nicholas Pollard como diretor em 01/12/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Quem são os diretores de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULLIVAN, John | Secretário | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210820120001 | |||||||
| COX, Paul Anthony | Diretor | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 153797870001 | |||||
| SULLIVAN, John Terence | Diretor | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 180046340001 | |||||
| ALLEN, Caroline Elizabeth | Secretário | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 208085190001 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Secretário | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
| JESKE, Riga | Secretário | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189290690001 | |||||||
| KAHVECI, Suheda | Secretário | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176235280001 | |||||||
| PHILLIPS, Elizabeth Clare | Secretário | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
| REED, Sophie Catherine Jane | Secretário | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198174110001 | |||||||
| SCOTT, Stephen John | Secretário nomeado | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002270001 | ||||||
| WELLS, Jennifer Ann | Secretário | 20a Collett Way Priorslee TF2 9SL Telford Salop | British | 63479470001 | ||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretário | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Diretor | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | 105363350001 | |||||
| GERSTROM, Peter Anton | Diretor | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 138719750001 | |||||
| HARRISON, Julian John | Diretor | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | 123927990001 | |||||
| HOLL, Alistair Myrie | Diretor | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | 138014840001 | |||||
| JOHNSON, Peter Stuart | Diretor | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | 11159620001 | |||||
| MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Diretor | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 140753960001 | |||||
| PHILLIPS, John | Diretor | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 343070001 | ||||||
| POLLARD, Charles Nicholas | Diretor | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 192011710001 | |||||
| RIDDLE, David Ellison | Diretor | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | 556710002 | |||||
| SCOTT, Jacqueline | Diretor nomeado | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002260001 | ||||||
| STEGGLES, Jonathan David | Diretor | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 45141530001 | |||||
| WARD, Malcolm John | Diretor | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 57775660003 | |||||
| WELLS, Peter | Diretor | 20a Collett Way Priorslee TF2 9SL Telford Salop | British | 45937400001 | ||||||
| WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Diretor | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | 92108930002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Hire Service Limited | 06/04/2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
IMCO RECONOMY 5 LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 20/08/2015 Entregue em 27/08/2015 | Totalmente satisfeita | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A supplemental common debenture | Criado em 29/11/2011 Entregue em 08/12/2011 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of accession | Criado em 18/05/2007 Entregue em 25/05/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 26/04/2005 Entregue em 11/05/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| First fixed and floating charge | Criado em 26/05/1999 Entregue em 04/06/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descrição A first fixed charge on all book and other debts as are not sold or bought by alex lawrie receivable financing limited under an agreement dated 2ND june 1999 and a floating charge all proceeds of book and other debts with the payment of any sum due or owing to alex lawrie receivables financing limited under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which both the company and alex lawrie receivables financing limited are a party. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0