IMCO RECONOMY 5 LIMITED

IMCO RECONOMY 5 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaIMCO RECONOMY 5 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03347372
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    • coleta de resíduos não perigosos (38110) / Captação, tratamento e distribuição de água; gestão de resíduos; atividades de descontaminação e recuperação

    Onde fica IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SKIPS@HOME LIMITED18/04/200718/04/2007
    WELLS FARGO SKIPS LIMITED08/04/199708/04/1997

    Quais são as últimas contas de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Declaração de confirmação apresentada em 08/04/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    16 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 08/04/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Endereço do domicílio registado alterado de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL para Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD em 26/07/2016

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr John Sullivan como secretário em 21/07/2016

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Richard Llewelyn Milnes-James como diretor em 21/07/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Charles Nicholas Pollard como diretor em 21/07/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Alistair Myrie Holl como diretor em 21/07/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Caroline Elizabeth Allen como secretário em 21/07/2016

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr John Terence Sullivan como diretor em 21/07/2016

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Paul Cox como diretor em 21/07/2016

    2 páginasAP01

    Satisfação total da garantia 033473720005

    4 páginasMR04

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04
    Anotações
    DataAnotação
    13/06/2016Clarification This document is a second filing of the TM02 registered on 12/05/2016 for Sophie Catherine Jane Reed

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    16 páginasAA

    Nomeação de Ms Caroline Elizabeth Allen como secretário em 11/04/2016

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Sophie Catherine Jane Reed como secretário em 01/04/2016

    2 páginasTM02
    Anotações
    DataAnotação
    13/06/2016Clarification A second filed TM02 was registered on 13/06/2016

    Declaração anual preparada até 08/04/2016 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital21/04/2016

    Estado do capital em 21/04/2016

    • Capital: GBP 10
    SH01

    Término da nomeação de Peter Anton Gerstrom como diretor em 01/12/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Charles Nicholas Pollard como diretor em 01/12/2015

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SULLIVAN, John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Secretário
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    210820120001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Diretor
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Diretor
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish180046340001
    ALLEN, Caroline Elizabeth
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretário
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    208085190001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretário
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretário
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189290690001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretário
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176235280001
    PHILLIPS, Elizabeth Clare
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Secretário
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British56302980001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretário
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198174110001
    SCOTT, Stephen John
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Secretário nomeado
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002270001
    WELLS, Jennifer Ann
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    Secretário
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    British63479470001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Secretário
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    32524900007
    DIXON, Sally Veronica
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    Diretor
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    EnglandBritish105363350001
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Diretor
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish138719750001
    HARRISON, Julian John
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    Diretor
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritish123927990001
    HOLL, Alistair Myrie
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Diretor
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    WalesBritish138014840001
    JOHNSON, Peter Stuart
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    Diretor
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish11159620001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Diretor
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish140753960001
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Diretor
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British343070001
    POLLARD, Charles Nicholas
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Diretor
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Diretor
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish556710002
    SCOTT, Jacqueline
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Diretor nomeado
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002260001
    STEGGLES, Jonathan David
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Diretor
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish45141530001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Diretor
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish57775660003
    WELLS, Peter
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    Diretor
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    British45937400001
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Diretor
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish92108930002

    Quem são as pessoas com controle significativo de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Waste Hire Service Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    06/04/2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroUk
    Número de registro03441128
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    IMCO RECONOMY 5 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 20/08/2015
    Entregue em 27/08/2015
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 27/08/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 25/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A supplemental common debenture
    Criado em 29/11/2011
    Entregue em 08/12/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 08/12/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 24/08/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Deed of accession
    Criado em 18/05/2007
    Entregue em 25/05/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transações
    • 25/05/2007Registro de uma garantia (395)
    • 24/08/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 26/04/2005
    Entregue em 11/05/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Cibc World Markets PLC
    Transações
    • 11/05/2005Registro de uma garantia (395)
    • 23/04/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    First fixed and floating charge
    Criado em 26/05/1999
    Entregue em 04/06/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descrição
    A first fixed charge on all book and other debts as are not sold or bought by alex lawrie receivable financing limited under an agreement dated 2ND june 1999 and a floating charge all proceeds of book and other debts with the payment of any sum due or owing to alex lawrie receivables financing limited under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which both the company and alex lawrie receivables financing limited are a party.
    Pessoas com direito
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transações
    • 04/06/1999Registro de uma garantia (395)
    • 05/05/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0