COMMUNISIS DATAFORM LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | COMMUNISIS DATAFORM LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 03357295 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de COMMUNISIS DATAFORM LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica COMMUNISIS DATAFORM LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Communisis House Manston Lane LS15 8AH Leeds |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de COMMUNISIS DATAFORM LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
DATAFORM GROUP LIMITED | 22/12/1997 | 22/12/1997 |
HOODCO 548 LIMITED | 22/04/1997 | 22/04/1997 |
Quais são as últimas contas de COMMUNISIS DATAFORM LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2019 |
Quais são as últimas submissões para COMMUNISIS DATAFORM LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Timothy Austin Burgham como diretor em 26/10/2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Steven Clive Rawlins como diretor em 26/10/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 24 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2019 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Steven Clive Rawlins como secretário em 28/02/2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Sarah Louise Caddy como secretário em 28/02/2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de Mr Steven Clive Rawlins como diretor em 28/02/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Sarah Louise Caddy como diretor em 28/02/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 23/01/2019 com atualizações | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Alteração dos detalhes de Communisis Plc como pessoa com controlo significativo em 10/12/2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2018 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2017 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 28/07/2016 com atualizações | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Quem são os diretores de COMMUNISIS DATAFORM LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAWLINS, Steven Clive | Secretário | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | 256372020001 | |||||||
BURGHAM, Timothy Austin | Diretor | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | United Kingdom | British | Finance Director | 274846850001 | ||||
RIDDLE, Jonathan Rowlatt Huber | Diretor | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | England | British | Tax Manager | 53609030001 | ||||
CADDY, Sarah Louise | Secretário | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | 146646390002 | |||||||
HOLBROOK, Bradley | Secretário | North Moor 36 Station Road Stannington NE61 6DU Morpeth Northumberland | British | Company Director | 50693590001 | |||||
HULLS, Martin Ashley | Secretário | 5 High Mill Road NE39 1HE Rowlands Gill Tyne & Wear | British | Solicitor | 71500060002 | |||||
MILTON, Keith Bertram | Secretário | 25 Rectory Grove NE3 1AL Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Company Secretary | 76950940001 | |||||
ROGAN, Eileen Theresa | Secretário nomeado | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | 900013580001 | ||||||
WARE, Andrew | Secretário | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | British | Director | 110947260001 | |||||
YOUNG, Martin Keay | Secretário | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | British | Company Secretary | 41926620002 | |||||
CADDY, Sarah Louise | Diretor | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | England | British | Company Secretary | 150731100003 | ||||
HOLBROOK, Bradley | Diretor | North Moor 36 Station Road Stannington NE61 6DU Morpeth Northumberland | England | British | Company Director | 50693590001 | ||||
HOLBROOK, Graham | Diretor | 19 Ashdale Mount Pleasant DH4 7SL Fatfield, Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | Sales Director | 50927850001 | |||||
HOLBROOK, Lorraine | Diretor | Northmoor Station Road NE61 6DU Stannington Northumberland | England | British | Housewife | 150672220001 | ||||
HULLS, Martin Ashley | Diretor | 5 High Mill Road NE39 1HE Rowlands Gill Tyne & Wear | British | Solicitor | 71500060002 | |||||
MACROBERT, Elizabeth Hannah | Diretor | 25 Kensington Avenue Gosforth NE3 2HP Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Solicitor | 56258460001 | ||||
MILTON, Keith Bertram | Diretor | 25 Rectory Grove NE3 1AL Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Company Secretary | 76950940001 | |||||
MORAN, Denise | Diretor | Beech House High Street Billingley S72 0HY Barnsley South Yorkshire | British | Director | 99531800001 | |||||
POWELL, Bruce Lewis Hamilton | Diretor | Broadhatch House Bentley GU10 5JJ Farnham Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 15809770001 | ||||
PYGALL, Christopher | Diretor | 1 Mulberry Close NE24 3XR Blyth Northumberland | British | Director | 56373380002 | |||||
RAWLINS, Steven Clive | Diretor | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | England | United Kingdom | Company Director | 240837130001 | ||||
ROGAN, Eileen Theresa | Diretor nomeado | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | 900013580001 | ||||||
SIMPSON, Paul Stephen | Diretor | The Corfields Pinfold Lane DN6 0ED Moss South Yorkshire | England | British | Director | 150743370001 | ||||
STEEN, John Matheson | Diretor | 33 Park View Felton NE65 9DQ Morpeth Northumberland | British | Company Director | 56207820003 | |||||
WARE, Andrew | Diretor | Cauldwell Snows Green Road DH8 0NJ Shotley Bridge Durham | United Kingdom | British | Director | 110947260001 | ||||
YOUNG, Martin Keay | Diretor | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Secretary | 41926620002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de COMMUNISIS DATAFORM LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communisis Limited | 06/04/2016 | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
|
COMMUNISIS DATAFORM LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Criado em 29/10/2003 Entregue em 11/11/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido The sum of £350,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of assignment | Criado em 18/12/1997 Entregue em 27/12/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição Life insurance policy issued by j rothschild international assurance LTD no. C5006628G over the life of bradley holbrook and all monies including bonuses accrued. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Deed of assignment | Criado em 18/12/1997 Entregue em 27/12/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descrição Life insurance policy issued by j rothschild international assurance LTD no. C5006627E over the life of john matheson steen and all monies including bonuses accrued. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 18/12/1997 Entregue em 27/12/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company (formerly known as hoodco 548 limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0