HI FINANCE PROPERTIES LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | HI FINANCE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03363702 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
- Hotéis e alojamentos semelhantes (55100) / Alojamento, restauração e similares
Onde fica HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| HOLIDAY INN FINANCE PROPERTIES LIMITED | 16/07/2002 | 16/07/2002 |
| COMPASS HOTEL PROPERTIES LIMITED | 31/01/2001 | 31/01/2001 |
| GRANADA HOTEL PROPERTIES LIMITED | 26/09/1997 | 26/09/1997 |
| 2036TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 01/05/1997 | 01/05/1997 |
Quais são as últimas contas de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2016 |
Quais são as últimas submissões para HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 17 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 29/11/2018 | 16 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Término da nomeação de Justin Bruce Robinson como diretor em 14/09/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
O endereço de inspeção do registo foi alterado para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 21/12/2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração de solvência | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Haysmacintyre Company Secretaries Limited em 18/12/2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Simon Michael Teasdale em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom para 10 Queen Street Place London EC4R 1AG em 18/12/2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Patrick Thomas Mabry em 18/12/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 033637020006 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado do capital em 03/10/2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/10/2017 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 033637020006 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Justin Bruce Robinson em 03/02/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/10/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Quem são os diretores de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Diretor | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Diretor | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretário | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Secretário | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Secretário | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203651900001 | |||||||||||
| MASON, Timothy Charles | Secretário | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Secretário | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Secretário | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secretário | Bishops Square Eighth Floor E1 6EG London Ten United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Secretário nomeado | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Stacey Lee | Diretor | 46 Chiddingstone Road SW6 3TG London | British | 37682070002 | ||||||||||
| CROSTON, Francis John | Diretor | 5 The Laurels Queenborough Lane CM77 7QD Braintree Essex | United Kingdom | British | 65219360003 | |||||||||
| DAVENPORT, Donald Andrew | Diretor | Ramsbury House 23 Badgers Hill Wentworth GU25 4SA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 13178710003 | |||||||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Diretor | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Diretor | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Diretor | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Diretor | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Diretor | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||||||
| MARTIN, Andrew David | Diretor | 5 Dalkeith Road AL5 5PP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 52743800001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Diretor | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Diretor | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| MITCHELL, Paul Raymond | Diretor | Waltons Farm Hollygreen Lane HP27 9PL Bledlow Bucks England | England | British | 148147140001 | |||||||||
| MORTIMER, David Grant | Diretor | 86 Frenchay Road OX2 6TF Oxford Oxfordshire | British | 47770480002 | ||||||||||
| NEWMAN, Mark | Diretor | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PARROTT, Graham Joseph | Diretor | Flat 1 27 Redington Road Hampstead NW3 7QY London | British | 6741720003 | ||||||||||
| PRINCE, Ryan David | Diretor | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Diretor | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Diretor | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STAUNTON, Henry Eric | Diretor | Fairfield Nursery Road KT20 7TZ Walton On The Hill Surrey | England | British | 37935500001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Diretor | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| STRETTON, Mark Nigel | Diretor | Top Cottage Upper Oddington GL56 0XN Moreton-In-Marsh | British | 95909440001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nas Cobalt No.2 Limited | 06/04/2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
HI FINANCE PROPERTIES LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 01/12/2015 Entregue em 02/12/2015 | Pendente | ||
Breve descrição F/H crest hotel filton road hambrook t/no.AV194979 and l/h the bloomsbury crest hotel coram stret t/no.NGL672413. Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A registered charge | Criado em 22/05/2013 Entregue em 03/06/2013 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição F/H basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409818, f/h black prince hotel southwold road bexley t/no SGL103988, f/h crest hotel filton road hambrook t/no AV194979, for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge. Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage | Criado em 20/06/2005 Entregue em 28/06/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descrição L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 20/06/2005 Entregue em 22/06/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 241097 | Criado em 24/10/1997 Entregue em 07/11/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The erskine crest hotel erskine renfrew t/n REN57421. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Legal charge | Criado em 24/10/1997 Entregue em 29/10/1997 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from granada group PLC to the chargee pursuant to the terms of the loan agreement of even date together with any other monies payable by the company to the chargee under the legal charge | |
Breve descrição Basingstoke posthouse (formerly basingstoke crest hotel) basingstoke hampshire T.no: HP409818; bexley posthouse (formerly k/a black prince public house) rochester way l/b of bexley t/no: SGL103988; bristol posthouse (formerly crest hotel) filton house hambrrok south gloucestershire t/no: AV194979. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
HI FINANCE PROPERTIES LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0