CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED

CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03374064
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    • Desenvolvimento de software empresarial e doméstico (62012) / Informação e comunicação

    Onde fica CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    THALES TELEMATICS PLC02/01/200202/01/2002
    THALES TELEMATICS PLC02/01/200202/01/2002
    GLOBAL TELEMATICS PLC15/05/199715/05/1997

    Quais são as últimas contas de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2012

    Qual é o status da última declaração anual para CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    12 páginas4.72

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 09/09/2013

    11 páginas4.68

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    2 páginasF10.2

    Endereço do domicílio registado alterado de * Priory Park Great North Road Aberford West Yorkshire LS25 3DF United Kingdom* em 20/09/2012

    2 páginasAD01

    Estado de situação patrimonial com formulário em anexo 4.19

    6 páginas4.20

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação

    LRESEX

    Contas anuais preparadas até 31/03/2012

    20 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 15/05/2012 com lista completa de acionistas

    3 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/05/2012

    Estado do capital em 15/05/2012

    • Capital: GBP 48,624,000
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Cybit Holdings Plc Cybit House Kingfisher Way Hinchingbrooke Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6FN* em 29/03/2012

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de Nicholas Williams como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de William Henry como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Paul Waterhouse como secretário

    1 páginasTM02

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2011 para 31/03/2012

    1 páginasAA01

    Nomeação de Mr Paul Francis Bosson como diretor

    2 páginasAP01

    Contas anuais preparadas até 31/03/2011

    20 páginasAA

    Nomeação de Mr Paul Keith Waterhouse como secretário

    1 páginasAP03

    Nomeação de Mr Nicholas Williams como diretor

    2 páginasAP01

    Exercício contabilístico atual encurtado de 31/03/2012 para 31/12/2011

    1 páginasAA01

    Quem são os diretores de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BOSSON, Paul Francis
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Diretor
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish82707040001
    BELCHER, John Victor
    5 Woodpecker Close
    Twyford
    RG10 0BB Reading
    Berkshire
    Secretário
    5 Woodpecker Close
    Twyford
    RG10 0BB Reading
    Berkshire
    British10018180001
    LAWRENCE, Kevin Brian
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    Secretário
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    British169886380001
    PRICE, Trevor Sheldon
    39 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    Secretário
    39 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    British47797870003
    SEABROOK, Michael William Peter
    40 Horsell Park Close
    Horsell
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Secretário
    40 Horsell Park Close
    Horsell
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    British70900110002
    WATERHOUSE, Paul Keith
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretário
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    165522040001
    PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    Secretário nomeado
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    900013000001
    AKBARI, Homaira
    5 Rue Du Pont De Lodi 75006
    FOREIGN Paris
    France
    Diretor
    5 Rue Du Pont De Lodi 75006
    FOREIGN Paris
    France
    American86832440001
    ASHTON, Max William Simon
    11 Holne Chase
    N2 0QP London
    Diretor
    11 Holne Chase
    N2 0QP London
    United KingdomBritish73381460001
    BARTLETT, Robert
    38 Ardingly
    Great Hollands
    RG12 8XR Bracknell
    Berkshire
    Diretor
    38 Ardingly
    Great Hollands
    RG12 8XR Bracknell
    Berkshire
    British71790550001
    BELGEONNE, Edward
    Winters Barn Cottage
    Frensham Lane
    GU35 8RU Headley
    Hampshire
    Diretor
    Winters Barn Cottage
    Frensham Lane
    GU35 8RU Headley
    Hampshire
    British4264610006
    BRUEGGER, Edmund Peter
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    Diretor
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    EnglandBritish13417490001
    BRUEGGER, Edmund Peter
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    Diretor
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    EnglandBritish13417490001
    CHEVREL, Roger Jean Marius
    16 Route Du Domaine
    Le Vesinet
    78110
    France
    Diretor
    16 Route Du Domaine
    Le Vesinet
    78110
    France
    French16515610001
    COLLINS, David Anthony
    First Floor, Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    Diretor
    First Floor, Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    British74345090001
    GALLAGHER, Daniel Joseph
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Diretor
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British And Irish49885010001
    GRIFFITHS, David Wynne
    6 Woodrough Copse
    Birtley Road Bramley
    GU5 0HH Guildford
    Surrey
    Diretor
    6 Woodrough Copse
    Birtley Road Bramley
    GU5 0HH Guildford
    Surrey
    British63953750001
    GUERIN, Stanislas Philippe
    116 Boulevard Raspail
    75006 Paris
    France
    Diretor
    116 Boulevard Raspail
    75006 Paris
    France
    French69237660001
    HARDY, Warren Andrew
    Great Gables Burkes Crescent
    HP9 1PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Great Gables Burkes Crescent
    HP9 1PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British68425480003
    HENRY, William Patrick
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    Diretor
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandAmerican119049370001
    HORNE, David Robert Geoffrey
    The Timbers
    Coronation Road Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    Diretor
    The Timbers
    Coronation Road Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    BritainBritish31020910002
    HORSMAN, Richard John
    House
    Wagon Lane
    TN2 6PT Paddock Wood
    High Lee Farm
    Kent
    England
    Diretor
    House
    Wagon Lane
    TN2 6PT Paddock Wood
    High Lee Farm
    Kent
    England
    United KingdomBritish160192730001
    LAGORMARSINO, Antoine Jean-Baptiste
    Heckfield Place
    Heckfield
    RG27 0LD Hook
    Hampshire
    Diretor
    Heckfield Place
    Heckfield
    RG27 0LD Hook
    Hampshire
    French78647480001
    LAWRENCE, Kevin Brian
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    Diretor
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    EnglandBritish169886380001
    MASSOL, Jose Andre
    18 Rue Des Clos Ribauds
    95550 Bessancourt
    FOREIGN France
    Diretor
    18 Rue Des Clos Ribauds
    95550 Bessancourt
    FOREIGN France
    British40427390001
    MCCREADY, James John
    Fairways
    28b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    Diretor
    Fairways
    28b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    United KingdomBritish426750003
    MCKINNEY, David
    11 Gordon Road
    SL4 3RG Windsor
    Berkshire
    Diretor
    11 Gordon Road
    SL4 3RG Windsor
    Berkshire
    British75154230001
    MORAUD, Jean-Louis
    8 Les Passereaux
    La Celle St Cloud
    78170
    France
    Diretor
    8 Les Passereaux
    La Celle St Cloud
    78170
    France
    French93664700001
    PALMER, Stuart Justin
    213 Arethusa Way
    Bisley
    GU24 9BT Woking
    Surrey
    Diretor
    213 Arethusa Way
    Bisley
    GU24 9BT Woking
    Surrey
    EnglandUnited Kingdom80123680001
    PRICE, Trevor Sheldon
    Garden Flat
    50a Elmgrove Road
    KT13 8PD Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Garden Flat
    50a Elmgrove Road
    KT13 8PD Weybridge
    Surrey
    British47797870005
    RICHARDSON, Martin Roger
    The Old Rectory Mill Lane
    HP27 9LG Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Diretor
    The Old Rectory Mill Lane
    HP27 9LG Monks Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish46804640002
    ROBERTS, Simon
    3 Conygree Close
    Lower Earley
    RG6 4XE Reading
    Berkshire
    Diretor
    3 Conygree Close
    Lower Earley
    RG6 4XE Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish43241480001
    SUGDEN, Neil
    Speranza
    1 Downs Road Compton
    RG20 6RE Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Speranza
    1 Downs Road Compton
    RG20 6RE Newbury
    Berkshire
    British30962840002
    WILLIAMS, Nicholas
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    Diretor
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish160931630001
    WOOD, Brian Richard
    Hillgate 5 Pilgrims Way
    RH2 9LE Reigate
    Surrey
    Diretor
    Hillgate 5 Pilgrims Way
    RH2 9LE Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish2475940001

    CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 23/08/2011
    Entregue em 06/09/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    £5,774 see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Cheshire West and Chester Borough Council
    Transações
    • 06/09/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 04/09/2012Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Debenture
    Criado em 07/03/2008
    Entregue em 14/03/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 14/03/2008Registro de uma garantia (395)
    • 04/09/2012Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Debenture
    Criado em 15/02/1999
    Entregue em 24/02/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Midland Bank PLC
    Transações
    • 24/02/1999Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 18/01/1999
    Entregue em 20/01/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in relation to service provider agreements in relation to subscribers or the subscriber base of the company or in relation to other agreements
    Breve descrição
    All chose in action, book and other debts now or in future owing to the company by subscribers of the company in relation to the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transações
    • 20/01/1999Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of charge
    Criado em 03/11/1997
    Entregue em 08/11/1997
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreement dated 3 november 1997 or otherwise in any manner whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all book debts and other debts; by way of first floating charge all book debts other debts and any other rights benefits or interest comprised in the subscriber base.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Vodafone Limited
    Transações
    • 08/11/1997Registro de uma garantia (395)
    • 04/09/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    10/09/2012Início da liquidação
    18/09/2014Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    David William Tann
    Bridge House London Bridge
    SE1 9QR London
    Profissional
    Bridge House London Bridge
    SE1 9QR London
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profissional
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0