MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED

MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMISYS GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03379662
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BROKERCARE LIMITED20/08/199720/08/1997
    CHANCEFLAME LIMITED02/06/199702/06/1997

    Quais são as últimas contas de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/05/2014

    Quais são as últimas submissões para MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    14 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 26/11/2016

    14 páginas4.68

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 27/11/2015

    LRESSP

    legacy

    60 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 7

    5 páginasMR05

    Estado do capital em 07/08/2015

    • Capital: GBP 126,727.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 29/07/2015
    RES13

    Nomeação de Mr Johannes Jacobus Olivier como diretor em 20/07/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Paul Woodward como diretor em 20/07/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 02/06/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital05/06/2015

    Estado do capital em 05/06/2015

    • Capital: GBP 126,727
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/05/2014

    14 páginasAA

    Nomeação de Mr Andrew Paul Woodward como diretor em 05/09/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Sanjay Patel como diretor em 28/08/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr John Van Harken como diretor em 31/07/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Elizabeth Mary Collins como diretor em 31/07/2014

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 02/06/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/06/2014

    Estado do capital em 04/06/2014

    • Capital: GBP 126,727
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/05/2013

    13 páginasAA

    Término da nomeação de Misys Corporate Director Limited como diretor

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomSouth African199516920001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    The Street Warninglid
    Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1 Portwood Cottage
    England
    England
    Secretário
    The Street Warninglid
    Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1 Portwood Cottage
    England
    England
    146627810001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretário
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretário
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretário
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretário
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secretário
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secretário
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro07036299
    170448630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROOK, Anthony Richard
    Crofftau
    Cantref
    LD3 8LL Brecon
    Powys
    Diretor
    Crofftau
    Cantref
    LD3 8LL Brecon
    Powys
    British44545910001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COOK, John
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    Diretor
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    EnglandBritish86208160001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    DUDLEY, John Mark
    Eagle Way
    Hampton Vale
    PE7 8EA Peterborough
    124
    England
    England
    Diretor
    Eagle Way
    Hampton Vale
    PE7 8EA Peterborough
    124
    England
    England
    UkBritish101918420001
    EVANS, Howard
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56986700002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Diretor
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    Diretor
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    EnglandBritish75357260001
    FLETCHER, Leonard James
    Long Cottage
    Compton Road
    RG20 7LH East Ilsley
    Berkshire
    Diretor
    Long Cottage
    Compton Road
    RG20 7LH East Ilsley
    Berkshire
    EnglandBritish74416740002
    FULLELOVE, Glyn William
    Brook House
    Spout Lane Tansley
    DE4 5FH Matlock
    Derbyshire
    Diretor
    Brook House
    Spout Lane Tansley
    DE4 5FH Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish73026210001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Diretor
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Diretor
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    JOHNSON, Russell Alan
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    Diretor
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    British130788060001
    LEWIS, Richard
    Karisaro 50 Slade Avenue
    Lyppard Hanford
    WR4 0HB Worcester
    Diretor
    Karisaro 50 Slade Avenue
    Lyppard Hanford
    WR4 0HB Worcester
    British71966870001
    MARSH, Howard Alexander David
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    Diretor
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    United KingdomBritish111938620001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Diretor
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MCMAHON, Jasper Philip
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    Diretor
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    EnglandBritish45080250003
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Diretor
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    Diretor
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Diretor
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    EnglandBritish80817560001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Diretor
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Diretor
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001

    MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 27/07/2012
    Entregue em 06/08/2012
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    Transações
    • 06/08/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 12/09/2015Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Criado em 19/12/2006
    Entregue em 29/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 29/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Criado em 17/09/2003
    Entregue em 01/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Criado em 11/09/2003
    Entregue em 24/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Criado em 29/07/2003
    Entregue em 12/08/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 12/08/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Criado em 23/10/2002
    Entregue em 13/11/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 13/11/2002Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Criado em 09/05/2002
    Entregue em 25/05/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 25/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    13/12/2017Data de dissolução
    27/11/2015Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Profissional
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0