SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03379663
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Outras edições de software (58290) / Informação e comunicação

    Onde fica SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    DEMOABLE LIMITED02/06/199702/06/1997

    Quais são as últimas contas de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/05/2014

    Quais são as últimas submissões para SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    11 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 26/05/2016

    28 páginas4.68

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 27/05/2015

    LRESSP

    Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 7

    5 páginasMR05

    Contas anuais preparadas até 31/05/2014

    15 páginasAA

    Nomeação de Mr Andrew Paul Woodward como diretor em 05/09/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Sanjay Patel como diretor em 28/08/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr John Van Harken como diretor em 31/07/2014

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Elizabeth Mary Collins como diretor em 31/07/2014

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 02/06/2014 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/06/2014

    Estado do capital em 04/06/2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/05/2013

    14 páginasAA

    Término da nomeação de Misys Corporate Director Limited como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Joanna Hawkes como diretor

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Misys Corporate Secretary Limited como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Sanjay Patel como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Elizabeth Mary Collins como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Bijal Patel como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Joanna Marageret Hawkes como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 02/06/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Bijal Mahendra Patel em 20/05/2013

    2 páginasCH01

    Contas anuais preparadas até 31/05/2012

    15 páginasAA

    Nomeação de Mr Bijal Mahendra Patel como diretor

    2 páginasAP01

    Quem são os diretores de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    Diretor
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    Secretário
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    British147213550001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretário
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretário
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretário
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretário
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secretário
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secretário
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro07036299
    170449400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAULME, Herve
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    Diretor
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    French98573020001
    BELLOUARD, Xavier Henry Marie
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    Diretor
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    LondonFrench53755850003
    BRIODY, Dermot
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    Diretor
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    Irish128090250001
    CAPPELL, Mark Stanley
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    Diretor
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    United KingdomAmerican103054980001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DE FONTENAY, Jean
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    Diretor
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    French53755800002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Diretor
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Diretor
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Diretor
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Diretor
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Diretor
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    HUGHES, Kevin Gerard
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    Diretor
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    British2659400001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Diretor
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MOLONEY, Barry William
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Diretor
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48187880001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Diretor
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SARGANT, Murray
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Diretor
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Australian113006830001
    SOAMES, Rupert Christopher
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Diretor
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    ScotlandBritish86671010001
    STONELL, Keith Robert
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    Diretor
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish151579610001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Diretor
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Diretor
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 27/07/2012
    Entregue em 06/08/2012
    Pendente
    Montante garantido
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    Transações
    • 06/08/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 18/05/2015Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Criado em 19/12/2006
    Entregue em 29/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 29/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Criado em 17/09/2003
    Entregue em 01/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Criado em 11/09/2003
    Entregue em 24/09/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/09/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Criado em 29/07/2003
    Entregue em 12/08/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 12/08/2003Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Criado em 23/10/2002
    Entregue em 13/11/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 13/11/2002Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Criado em 09/05/2002
    Entregue em 25/05/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 25/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    06/10/2017Data de dissolução
    27/05/2015Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Profissional
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0