GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED

GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03394337
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED?

    • desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção

    Onde fica GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PREMIER HOMES (EAST ANGLIA) LIMITED20/06/200120/06/2001
    BELGRAVIA FURNISHINGS LIMITED27/06/199727/06/1997

    Quais são as últimas contas de GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Qual é o status da última declaração anual para GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 22/12/2015

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Reduce share prem a/c to nil 15/10/2015
    RES13

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2015 para 30/04/2016

    1 páginasAA01

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Glyn David Mabey em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Colin Edward Lewis em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Giles Henry Sharp em 22/10/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 22/10/2015

    1 páginasCH03

    Endereço do domicílio registado alterado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG para Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP em 23/10/2015

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA

    Declaração anual preparada até 20/06/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital22/06/2015

    Estado do capital em 22/06/2015

    • Capital: GBP 250
    SH01

    Término da nomeação de Jon William Mortimore como diretor em 31/03/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Giles Sharp como diretor em 23/01/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Neil Fitzsimmons como diretor em 12/12/2014

    1 páginasTM01

    Satisfação total da garantia 13

    4 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 14

    4 páginasMR04

    Detalhes do secretário alterados para Joanne Elizabeth Massey em 15/12/2014

    1 páginasCH03

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2013

    6 páginasAA

    Término da nomeação de Warren Thompson como diretor em 08/09/2014

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Glyn David Mabey como diretor em 15/09/2014

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 20/06/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital20/06/2014

    Estado do capital em 20/06/2014

    • Capital: GBP 250
    SH01

    Quem são os diretores de GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secretário
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808210001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    MABEY, Glyn David
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector100945610001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Diretor
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretário
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    ROGERS, Cyril William
    Walcis Farm
    Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    Norfolk
    Secretário
    Walcis Farm
    Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    Norfolk
    British4783390001
    SKIPPER, Anthony Gordon
    13 Attlebridge Post Office
    Station Road Attlebridge
    NR9 5AA Norwich
    Secretário
    13 Attlebridge Post Office
    Station Road Attlebridge
    NR9 5AA Norwich
    BritishSecretary53870190001
    WILSON, Steven Mark
    6 Saint Peters Road
    Lingwood
    NR13 4LX Norwich
    Norfolk
    Secretário
    6 Saint Peters Road
    Lingwood
    NR13 4LX Norwich
    Norfolk
    British69992130001
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Secretário nomeado
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    ASKER, Giles Allen Trevor
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Diretor
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector75879360004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    COLLS, Andrew John
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant61370150001
    CUBITT, Richard
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    Diretor
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    EnglandBritishCompany Secretary114403390001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Diretor
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Diretor
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Diretor
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Diretor
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    HIRST, Stephen Jeremy
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    Diretor
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95787000001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo207729000002
    ROGERS, Maureen
    Walcis Lodge
    Fakenham Road, Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    Norfolk
    Diretor
    Walcis Lodge
    Fakenham Road, Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector92830130001
    ROGERS, Naomi Dawn Elizabeth
    Walcis Lodge
    Fakenham Road, Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    Norfolk
    Diretor
    Walcis Lodge
    Fakenham Road, Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    Norfolk
    BritishDirector92830220001
    ROGERS, Paul David
    Walcis House
    Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    Diretor
    Walcis House
    Lenwade
    NR9 5QR Norwich
    EnglandBritishDirector39871740004
    SERRUYS, Andre Paul
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    Diretor
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    BritishCompany Director33476230001
    THOMPSON, Warren, Mr.
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Diretor
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector163768230001
    WILSON, Steven Mark
    6 St Peters Road
    Lingwood
    NR13 4LX Norwich
    Norfolk
    Diretor
    6 St Peters Road
    Lingwood
    NR13 4LX Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishAccountant82763920001
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Diretor nomeado
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    GLADEDALE (EAST ANGLIA) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 30/12/2008
    Entregue em 09/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 09/01/2009Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 02/05/2006
    Entregue em 16/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 07/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 02/05/2006
    Entregue em 13/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land lying to the east of white street martham t/no NK301370. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 02/05/2006
    Entregue em 13/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Hi tech house st saviours lane norwich t/no NK45321. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 02/05/2006
    Entregue em 13/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land lying to the east of white street martham t/no NK275615. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 02/05/2006
    Entregue em 13/05/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land on the west side of chapel break road norwich (lake land rise) t/no NK277967. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 13/05/2006Registro de uma garantia (395)
    • 13/07/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage deed
    Criado em 05/09/2005
    Entregue em 09/09/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a hi tech house, st saviours lane, norwich, norfolk t/n NK45321. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 09/09/2005Registro de uma garantia (395)
    • 17/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 10/01/2005
    Entregue em 18/01/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum of sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 18/01/2005Registro de uma garantia (395)
    • 17/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage deed
    Criado em 13/12/2004
    Entregue em 24/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a land on the west side of chapel break road, norwich t/n NK277967. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 17/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage deed
    Criado em 13/12/2004
    Entregue em 24/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a land on the east side of white street, martham t/n NK301370. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 17/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage deed
    Criado em 13/12/2004
    Entregue em 24/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H property k/a land lying to the east side of white street, martham t/n NK275615. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 17/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 31/10/2003
    Entregue em 04/11/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land lying to the east of white street, martham, norfolk t/n's NK275615 and NK263548. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 04/11/2003Registro de uma garantia (395)
    • 20/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal charge
    Criado em 14/10/2003
    Entregue em 16/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Land lying to the west side of chapel break road, norwich, norfolk t/no NK277967. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 20/04/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 14/10/2003
    Entregue em 16/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 16/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 03/03/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0