GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD
Visão geral
| Nome da empresa | GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03418652 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
- Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Endereço do escritório registrado | Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED | 14/10/1997 | 14/10/1997 |
| PRECIS (1570) LIMITED | 13/08/1997 | 13/08/1997 |
Quais são as últimas contas de GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2020 |
Quais são as últimas submissões para GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD England para Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ em 10/12/2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaração de solvência | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Término da nomeação de Vanessa Claire Balshaw como diretor em 04/10/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2020 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2019 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 15/07/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Vanessa Claire Balshaw em 20/04/2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Término da nomeação de Fiona Jane Conway Blakemore como diretor em 12/12/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Tania Inge Maria Cruickshank como secretário em 13/09/2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2018 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 09/07/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomea ção de Vanessa Claire Balshaw como diretor em 01/07/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Ms Fiona Jane Conway Blakemore como diretor em 29/03/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de George Edmund Richard Wood como diretor em 29/03/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Elizabeth Anne Woods em 22/08/2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Término da nomeação de John Spencer Morton como diretor em 30/11/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Susan Crichton Kilgour como diretor em 30/11/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 09/07/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUICKSHANK, Tania Inge Maria | Secretário | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Trading Limited | 262588700001 | |||||||||||
| WOODS, Elizabeth Anne | Secretário | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Trading Limited | 185427240002 | |||||||||||
| KILGOUR, Susan Crichton | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | British | 253138710001 | |||||||||
| DANIELS, Lisa Jane | Secretário | Curzon Street W1J 5HB London One United Kingdom | 158116950001 | |||||||||||
| GUEST, Robert Austin | Secretário | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | British | 44314180001 | ||||||||||
| GUEST, Robert Austin | Secretário | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | British | 44314180001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Secretário | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 73601950001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Secretário | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 73601950001 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretário | Upper Bank Street E14 5JJ London 10 | 139030920001 | |||||||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Secretário | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Secretário | 1st Floor 9 Cloak Lane EC4R 2RU London Pellipar House United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| BALSHAW, Vanessa Claire | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | British | 260166390002 | |||||||||
| BATAILLE, Alain | Diretor | 47 Onslow Square SW7 3LR London | French | 79407390001 | ||||||||||
| BATES, Mikkel Gascoigne | Diretor | 89 Boyne Road SE13 5AN London | England | British | 57415660001 | |||||||||
| BLAKEMORE, Fiona Jane Conway | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House England | England | British | 120501860002 | |||||||||
| BUFFET, Alex Jaques Guy | Diretor | 37 Alexandra Court 171/175 Queensgate SW7 5HQ London | French | 37269510001 | ||||||||||
| FILBY, Simon Edward | Diretor | 2 Lassa Road Eltham SE9 6PU London | British | 102816560001 | ||||||||||
| FUSCHILLO, Dino | Diretor | 75 Noel Road N1 8HE London | United Kingdom | British | 56486620002 | |||||||||
| GILMARTIN, Kevan Stuart | Diretor | Bremhill The Common HP4 2QF Berkhamsted Hertfordshire | British | 92667680001 | ||||||||||
| GREIG, Jonathan | Diretor | 93 Clarendon Road W11 4JG London | England | British | 141566980001 | |||||||||
| GUEST, Robert Austin | Diretor | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | Uk | British | 44314180001 | |||||||||
| HILD, Stephane Jean | Diretor | 47 Onslow Square SW7 3LR London | French | 37800820001 | ||||||||||
| HORLICK, Nicola Karina Christina | Diretor | 30 Thurloe Square SW7 2SD London | British | 53458480002 | ||||||||||
| IONS, John Stephen | Diretor | 1 Framfield Road Highbury N5 1UU London | United Kingdom | British | 42905720002 | |||||||||
| JOBBINS, Alison | Diretor | 14 Ingress Park Avenue DA9 9XJ Greenhithe Kent | British | 120824590001 | ||||||||||
| LAGRANGE, Pierre Philippe Alexandre | Diretor | Curzon Street W1J 5HB London One United Kingdom | England | Belgian | 161184130001 | |||||||||
| LEEMAN, Matthew | Diretor | Old Orchard House Harpsden RG9 4AX Henley On Thames | British | 102816450001 | ||||||||||
| MCKELLICK, Christopher James | Diretor | 51 Harrow Drive RM11 1NT Hornchurch Essex | British | 26238410001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House England | United Kingdom | British | 73601950003 | |||||||||
| MORTON, John Spencer | Diretor | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 73601950001 | |||||||||
| MURRAY, Malcolm Alexander | Diretor | 46 Copsem Lane KT10 9HJ Esher Surrey | United Kingdom | British | 31353770002 | |||||||||
| NUSSEIBEH, Saker Anwar, Dr | Diretor | 21 Palace Gate W8 5LY London | British | 91855640001 | ||||||||||
| O'SULLIVAN, Brian Christopher | Diretor | 10 Hadley Road EN5 5HH Barnet Hertfordshire | British | 47118120001 | ||||||||||
| PAGNI, Patrick Robert Marie | Diretor | 24 Thurloe Square SW7 2SD London | French | 33420570003 |
Quem são as pessoas com controle significativo de GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glg Partners Uk Group Ltd | 06/04/2016 | One Curzon Street W1J 5HB London One Curzon Street England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Criado em 16/03/2004 Entregue em 23/03/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The equitable interest in the sum of £226,100.00 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Rent deposit deed | Criado em 16/03/2004 Entregue em 23/03/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The sum of £65,887.50 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed | Criado em 27/03/2002 Entregue em 28/03/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The company's equitable interest in: (a) £65,887.50 to be paid by the company to the landlord no later than 27 march 2003 and which the landlord is obliged under the deed to pay into the account; and (b) any other sums paid into that account by the company pursuant to the deed and any interest credited to that account which has not been released to the company. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Rent deposit deed | Criado em 30/06/2000 Entregue em 04/07/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the above deed | |
Breve descrição The equitable interest in the securitydeposit. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0