CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED

CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03441143
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED?

    • outras impressões n.e.c. (18129) / Indústrias transformadoras

    Onde fica CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o RENDLE & CO LIMITED
    No 9 Hockley Court
    Hockley Heath
    Solihull
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    WYNDEHAM PRINT DIRECT LIMITED16/10/200216/10/2002
    PRINT DIRECT LIMITED09/08/200109/08/2001
    PRINT DIRECT HOLDINGS LIMITED06/04/199806/04/1998
    BROOMCO (1377) LIMITED29/09/199729/09/1997

    Quais são as últimas contas de CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Qual é o status da última declaração anual para CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    15 páginas4.72

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    3 páginasF10.2

    Estado de situação patrimonial com formulário em anexo 4.19

    5 páginas4.20

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução extraordinária para a liquidação em 16/04/2015

    LRESEX

    Endereço do domicílio registado alterado de 238 Nether Street London N3 1HU England para C/O Rendle & Co Limited No 9 Hockley Court Hockley Heath Solihull em 14/04/2015

    1 páginasAD01

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Change company name 09/03/2015
    RES13

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Satisfação total da garantia 7

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 10

    1 páginasMR04

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed wyndeham print direct LIMITED\certificate issued on 09/03/15
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name09/03/2015

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Endereço do domicílio registado alterado de Bentalls Complex Colchester Road Heybridge Essex CM9 4NW para 238 Nether Street London N3 1HU em 09/03/2015

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mr Peter James Martindale como diretor em 09/03/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Zoe Repman como diretor em 09/03/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Zoe Repman como secretário em 09/03/2015

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Debbie Read como diretor em 09/03/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Richard Charles Fookes como diretor em 09/03/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Paul George Utting como diretor em 09/03/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Roy Ernest Kingston como diretor em 09/03/2015

    1 páginasTM01

    Registo da garantia 034411430012, criada em 19/12/2014

    15 páginasMR01

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 29/09/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital30/09/2014

    Estado do capital em 30/09/2014

    • Capital: GBP 2,143,484
    SH01

    Término da nomeação de Ian Richard Mackintosh como diretor em 26/09/2014

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MARTINDALE, Peter James
    Nether Street
    N3 1HU London
    238
    England
    Diretor
    Nether Street
    N3 1HU London
    238
    England
    EnglandBritishCompany Director195681140001
    HARESNAPE, Christopher Paul
    3 Furness Close
    Poynton
    SK12 1QN Stockport
    Cheshire
    Secretário
    3 Furness Close
    Poynton
    SK12 1QN Stockport
    Cheshire
    British64447180002
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Secretário
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    BritishChartered Accountant15201600002
    REPMAN, Zoe
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    Secretário
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    146251100001
    UTTING, Paul George
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Secretário
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    British65550960004
    WHITWORTH, Anthony Elliott
    Highfield House
    Peover Lane Chelford
    SK11 9AW Macclesfield
    Cheshire
    Secretário
    Highfield House
    Peover Lane Chelford
    SK11 9AW Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director54616890001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretário nomeado
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BEDSON, Bryan Stanley
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    Diretor
    The Old Rectory
    Patching
    BN13 3XF Arundel
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director18576770001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Diretor
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant152718990001
    DARWIN, Beverley
    10 Denewood Court
    Victoria Road
    SK9 5HP Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    10 Denewood Court
    Victoria Road
    SK9 5HP Wilmslow
    Cheshire
    BritishSales Director85502350002
    FOOKES, Richard Charles
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector81522540002
    HARESNAPE, Christopher Paul
    3 Furness Close
    Poynton
    SK12 1QN Stockport
    Cheshire
    Diretor
    3 Furness Close
    Poynton
    SK12 1QN Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant64447180002
    HODGSON, Alan Robert
    The Ganies 8 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    The Ganies 8 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector56408480001
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Diretor
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant15201600002
    KINGSTON, Roy Ernest
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer97038180001
    LASHAM, Gary
    8 Pevensy Drive
    WA16 9BX Knutsford
    Cheshire
    Diretor
    8 Pevensy Drive
    WA16 9BX Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector102512840001
    MACKINTOSH, Ian Richard
    2 Redesmere Close
    SK10 3SJ Macclesfield
    Cheshire
    Diretor
    2 Redesmere Close
    SK10 3SJ Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishDirector117561900001
    PAGE, Andrew Stephen
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    Diretor
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector86557080001
    READ, Debbie
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Commercial Director183826490001
    REPMAN, Zoe
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    Diretor
    Colchester Road
    CM9 4NW Heybridge
    Bentalls Complex
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director183918910001
    TAYLOR, George Ivan
    Oakmead 29 Styal Road
    SK9 4AG Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    Oakmead 29 Styal Road
    SK9 4AG Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director56408590001
    THORNLEY, Colin
    Spindrift 30 Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TR Altrincham
    Cheshire
    Diretor
    Spindrift 30 Brooks Drive
    Halebarns
    WA15 8TR Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director10378060002
    UTTING, Paul George
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Diretor
    2 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    EnglandBritishDirector65550960004
    WHITWORTH, Anthony Elliott
    Highfield House
    Peover Lane Chelford
    SK11 9AW Macclesfield
    Cheshire
    Diretor
    Highfield House
    Peover Lane Chelford
    SK11 9AW Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director54616890001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Diretor nomeado
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Diretor nomeado
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 19/12/2014
    Entregue em 03/01/2015
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Wyndeham Press Group Limited
    Transações
    • 03/01/2015Registro de uma garantia (MR01)
    Debenture
    Criado em 06/04/2011
    Entregue em 14/04/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 14/04/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Debenture
    Criado em 06/04/2011
    Entregue em 15/04/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Cigala LLP
    Transações
    • 15/04/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 10/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Full form debenture
    Criado em 06/07/2010
    Entregue em 07/07/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Leumi Abl Limited
    Transações
    • 07/07/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 26/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Full form debenture
    Criado em 05/12/2008
    Entregue em 19/12/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Leumi Abl Limited
    Transações
    • 19/12/2008Registro de uma garantia (395)
    • 26/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 01/12/2006
    Entregue em 08/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transações
    • 08/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 10/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Chattels mortgage
    Criado em 01/12/2006
    Entregue em 08/12/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Assigns by way of security the mortgaged chattels,the benefit of any obligations,guarantees and warranties undertaken or given,all maintenance or support agreements,all authorisations,the benefit of the insurance proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Landsbanki Commercial Finance
    Transações
    • 08/12/2006Registro de uma garantia (395)
    • 11/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of accession and restatement
    Criado em 07/06/2006
    Entregue em 13/06/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Property being, the bentalls complex, colchester road, maldon, essex t/no EX443872. Castle press, 371, victoria street,grimsby t/no HS165423. Unit 11/12 grange industrial estate, grange road, southwick, west sussex t/no WSX142782. For details of further property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Landsbanki Islands Hf (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) the Security Trustee
    Transações
    • 13/06/2006Registro de uma garantia (395)
    • 03/02/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 26/11/2004
    Entregue em 11/12/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 11/12/2004Registro de uma garantia (395)
    • 03/11/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 04/02/2002
    Entregue em 04/02/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All and singular the chattels plant machinery etc:- goebel optiforma plus printing press s/no. 9029 and goebel printing inserts and cylinders s/nos 200031 and 200033.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transações
    • 04/02/2002Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/12/1997
    Entregue em 10/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 10/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 01/02/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit agreement and charge
    Criado em 31/12/1997
    Entregue em 10/01/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a counter indemnity of even date in any manner whatever and/or this deposit agreement
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all such right title and interest in the deposit and the accounts as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. Schedule - the deposit with the bank's treasury division in the name of broomco (1377) limited denominated in sterling and now numbered 0493928 and any deposit(s) (in whatever currency denominated) at any time made in renewal or replacement of any deposit(s) referred to in the schedule.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 10/01/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/05/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CASTLEHILL PRINT DIRECT LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    27/09/2016Data prevista de dissolução
    16/04/2015Início da liquidação
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Richard Paul Rendle
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    Profissional
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0