CAPARO ENGINEERING LIMITED

CAPARO ENGINEERING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCAPARO ENGINEERING LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03450375
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    • fundição de ferro (24510) / Indústrias transformadoras
    • fundição de outros metais não ferrosos (24540) / Indústrias transformadoras
    • fabricação de outros produtos fabricados em metal n.e.c. (25990) / Indústrias transformadoras

    Onde fica CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    SUPREMO 2000 LIMITED15/10/199715/10/1997

    Quais são as últimas contas de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Quais são as últimas submissões para CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    23 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2023

    23 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2022

    22 páginasLIQ03

    Pedido de insolvência

    Insolvency:secreatary of state release of liquidator.
    1 páginasLIQ MISC

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2021

    23 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    15 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    13 páginasLIQ10

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2020

    24 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 25/10/2019

    25 páginasLIQ03

    Pedido de insolvência

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 páginasLIQ MISC

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    17 páginasLIQ10

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Aviso de mudança da administração para liquidação voluntária de credores

    34 páginasAM22

    Relatório de progresso do administrador

    32 páginasAM10

    Endereço do domicílio registado alterado de 7 More London Riverside London SE1 2RT para Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL em 07/10/2017

    2 páginasAD01

    Aviso de extensão do período da administração

    3 páginasAM19

    Relatório de progresso do administrador

    29 páginasAM10

    Aviso de renúncia de um administrador

    11 páginas2.38B

    Relatório de progresso do administrador até 18/10/2016

    27 páginas2.24B

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Resultado da reunião dos credores

    1 páginas2.23B

    Relatório de progresso do administrador até 18/04/2016

    32 páginas2.24B

    Término da nomeação de Derek Michael O'reilly como diretor em 17/12/2015

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de CAPARO ENGINEERING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Diretor
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    BENNETT, Paul Richard
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    Secretário
    1 Ennerdale Drive
    B63 1HL Halesowen
    West Midlands
    British76951010001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Secretário nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Secretário
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    British126516810001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Secretário
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    BEATON, Kevin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish150211630001
    BOTTING, Richard Graham
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    Diretor
    7 Bromwich Drive
    WS13 8SD Fradley
    Staffordshire
    British85897150001
    BUTLER, Richard Gareth John
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish117859680001
    CLIFF, Richard Martyn
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    Diretor
    Waterside House
    Church Street Wyre Piddle
    WR10 2JD Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritish56113440001
    CURRAN, James Thomas
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    Diretor
    The Old Post Office
    10 Hill View Road Strensham
    WR8 9LJ Worcester
    United KingdomBritish56844020001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Diretor
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    GANE, Christopher Nigel
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    ScotlandBritish73268030001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Diretor nomeado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HAMMOND, Christopher Mark
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    United KingdomBritish60992860002
    HARTLAND, Melvyn Edward
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    Diretor
    7 Merriemont Drive
    Barnt Green
    B45 8QZ Birmingham
    British8436920002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Diretor
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish108440160002
    PAUL, Akhil
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish199010800001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Diretor
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAY, Jason Christopher
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish126516810001
    PAY, Jason Christopher
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    Diretor
    44 Osmaston Road
    DY8 2AL Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish126516810001
    PINCHES, Brian Michael
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    Diretor
    2 Berkeley Close
    Perton
    WV6 7RX Wolverhampton
    West Midlands
    British44065140001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Diretor
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    TAYLOR, Paul
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    Diretor
    86 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SL Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish49786260004
    UNDERHILL, Maurice
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    Diretor
    339 Birmingham Road
    WS5 3NU Walsall
    West Midlands
    British12842580001
    WHALE, Ian
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish192902390001
    WOOD, John Franklin
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Diretor
    Caparo House
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    EnglandBritish1397720001
    WOOD, John Franklin
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    27 Oak Hill Drive
    Edgbaston
    B15 3UG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish1397720001

    CAPARO ENGINEERING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 20/02/2014
    Entregue em 13/03/2014
    Pendente
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Caparo PLC
    Transações
    • 13/03/2014Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 27/06/2013
    Entregue em 15/07/2013
    Pendente
    Breve descrição
    F/H property. Caparo testing, brenda road, hartlepool t/no CE52039.. Caparo forgoing, marriott road, dudley t/no WM383778. (For details of patents charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Transações
    • 15/07/2013Registro de uma garantia (MR01)
    A registered charge
    Criado em 27/06/2013
    Entregue em 05/07/2013
    Pendente
    Breve descrição
    F/H land at caparo testing brenda road hartlepool t/no CE52039. F/h land at caparo forging marriott road dudley t/no WM383778. Patent described as "mounting (cmt own shock absorber)" filed in 1998 with number GB2330642. For details of further intellectual property please refer to deed. Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transações
    • 05/07/2013Registro de uma garantia (MR01)
    Polish law registered pledge agreement
    Criado em 19/08/2011
    Entregue em 25/08/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000 (say: fifty million zlotys), all the rights. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Caparo PLC
    Transações
    • 25/08/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Polish law registered pledge agreement
    Criado em 19/08/2011
    Entregue em 25/08/2011
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000 (say: ten million euro), all the rights. See image for full details.
    Pessoas com direito
    • Jalia Holding S.A.
    Transações
    • 25/08/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Pledge agreement
    Criado em 30/11/2010
    Entregue em 10/12/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of pln 50,000,000.
    Pessoas com direito
    • Caparo PLC
    Transações
    • 10/12/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Pledge agreement
    Criado em 26/11/2010
    Entregue em 10/12/2010
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All shares as the security for the payment of the secured receivable in the maximum amount of eur 10,000,000.
    Pessoas com direito
    • Jalia Holding Sa
    Transações
    • 10/12/2010Registro de uma garantia (MG01)
    Security agreement
    Criado em 30/07/2010
    Entregue em 06/08/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/08/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/07/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest and on other debts and floating charge on proceeds of other debts
    Criado em 31/01/2002
    Entregue em 14/02/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    (I) fixed equitable charge any debt (as defined in the agreement) purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement including its related rights (purchased debts) both present and future which fail to vest absolutely and effectively in the chargee for any reason and (ii) fixed equitable charge all amounts of indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever including the related rights, other than any purchased debt (other debts) and (iii) floating charge such monies the company may receive in respect of the other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 14/02/2002Registro de uma garantia (395)
    • 03/07/2013Satisfação de uma garantia (MR04)

    CAPARO ENGINEERING LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    19/10/2015Início da administração
    26/10/2018Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profissional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    2
    DataTipo
    26/10/2018Início da liquidação
    21/05/2024Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profissional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profissional
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0