GATEWAY OFFSITE LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaGATEWAY OFFSITE LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03453040
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de GATEWAY OFFSITE LTD?

    • (7499) /

    Onde fica GATEWAY OFFSITE LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Unicorn House Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de GATEWAY OFFSITE LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BRITSPACE HOTELS LIMITED09/12/200809/12/2008
    GATEWAY FABRICATIONS LIMITED29/12/199729/12/1997
    TALKTOP LIMITED21/10/199721/10/1997

    Quais são as últimas contas de GATEWAY OFFSITE LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/03/2010

    Quais são as últimas submissões para GATEWAY OFFSITE LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Término da nomeação de Matthew Cowan como secretário em 30/09/2011

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Término da nomeação de Ian Sherriff como secretário

    1 páginasTM02

    Nomeação de Matthew Cowan como secretário

    1 páginasAP03

    Endereço do domicílio registado alterado de Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR United Kingdom em 28/06/2011

    1 páginasAD01

    Endereço do domicílio registado alterado de Unicorn House Broad Lane Gilberdyke Brough East Yorkshire HU15 2TS em 27/06/2011

    1 páginasAD01

    Término da nomeação de James Bradney como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Christopher Harris como diretor

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Terence Jackson como diretor

    1 páginasTM01

    Nomeação de James Bradney como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Christopher John Huckle como diretor

    2 páginasAP01

    Declaração anual preparada até 21/10/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital26/10/2010

    Estado do capital em 26/10/2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2010

    6 páginasAA

    Nomeação de Mr Ian Sherriff como secretário

    1 páginasAP03

    Término da nomeação de Stephen Clarke como secretário

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/03/2009

    12 páginasAA

    legacy

    11 páginasMG01

    legacy

    5 páginasMG01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Quem são os diretores de GATEWAY OFFSITE LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HARRIS, David Christopher
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish76088090001
    HUCKLE, Christopher John
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141831160001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Secretário
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    British63261140001
    CLARKE, Stephen
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Secretário
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    British122285190001
    COWAN, Matthew
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    161230490001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Secretário
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    British19792670001
    HORNCASTLE, Carole Diane
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    Secretário
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    British79178970001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Secretário
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Secretário
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SHERRIFF, Ian
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    Secretário
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    149407420001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Secretário
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, Stewart Martin
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    Diretor
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish100469640001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Diretor
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Diretor
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BEALES, Stuart Patrick
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    Diretor
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    United KingdomBritish136886810001
    BRADNEY, James
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Diretor
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish161101450001
    CLARK, William Angus
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    Diretor
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    British80223540001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Diretor
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish19792670001
    HARRIS, David Christopher
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    Diretor
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish76088090001
    HORNCASTLE, Andrew Nigel
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    Diretor
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish4456360002
    JACKSON, Terence William
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    Diretor
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    UkBritish132410210001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Diretor
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Diretor
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SCANLAN, Sarah Rebecca
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    Diretor
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    British55408650001
    TAYLOR, Malcolm
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    Diretor
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    EnglandBritish83888440001
    TREBBLE, Stephen Paul
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    Diretor
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    EnglandBritish76640730001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Diretor
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GATEWAY OFFSITE LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 16/11/2009
    Entregue em 20/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 20/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 08/08/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 16/11/2009
    Entregue em 20/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 20/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 08/08/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Criado em 06/11/2009
    Entregue em 18/11/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Nvm Private Equity Limited
    Transações
    • 18/11/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 08/08/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 03/10/2008
    Entregue em 18/10/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Nvm Private Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transações
    • 18/10/2008Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 12/09/2002
    Entregue em 19/09/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Northern Venture Managers Limited
    Transações
    • 19/09/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Criado em 12/09/2002
    Entregue em 19/09/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies and liabilities due or to become due from the company and by any other company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 19/09/2002Registro de uma garantia (395)
    • 29/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/03/2000
    Entregue em 17/04/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 17/04/2000Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 31/03/2000
    Entregue em 06/04/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Horncastle Group PLC
    Transações
    • 06/04/2000Registro de uma garantia (395)
    • 29/11/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0