TI MAGAZINES (UK) LIMITED

TI MAGAZINES (UK) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTI MAGAZINES (UK) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03483202
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    • Atividades de outras sociedades holding n.e.c. (64209) / Atividades financeiras e de seguros

    Onde fica TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    6th Floor 60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    IPC MAGAZINES (UK) LIMITED03/02/199803/02/1998
    EXCESSTOP LIMITED18/12/199718/12/1997

    Quais são as últimas contas de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 03/03/2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account 02/03/2020
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 02/03/2020

    • Capital: GBP 30,140.6603
    3 páginasSH01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 20/02/2018

    • Capital: GBP 301,406,602
    8 páginasSH01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/12/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2018 para 30/06/2019

    1 páginasAA01

    Endereço do domicílio registado alterado de 3rd Floor 161 Marsh Wall London E14 9AP England para 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR em 20/08/2018

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    18 páginasAA

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name11/06/2018

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Término da nomeação de Lauren Ezrol Klein como secretário em 31/01/2018

    1 páginasTM02

    Término da nomeação de Marcus Alvin Rich como diretor em 13/03/2018

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen John May como diretor em 13/03/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Joseph Henry Ceryanec como diretor em 15/02/2018

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr John Stanley Zieser como diretor em 15/02/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Susana D'emic como diretor em 31/01/2018

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/12/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2016

    15 páginasAA

    Alteração dos detalhes de Time Uk Publishing Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 04/06/2016

    2 páginasPSC05

    Notificação de Time Inc. como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016

    2 páginasPSC02

    Quem são os diretores de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CERYANEC, Joseph Henry
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    Diretor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    United StatesAmerican243478830001
    ZIESER, John Stanley
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    Diretor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    United StatesAmerican217687580001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Secretário
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Secretário
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    KLEIN, Lauren Ezrol
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    Secretário
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    British127397780001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Secretário
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    British36233000002
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Secretário
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Secretário
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Secretário
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Diretor
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Diretor
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    British78644420001
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Diretor
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Diretor
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsa127283350001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Diretor
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    British67232740001
    BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr.
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Diretor
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    UsaAmerican181954550002
    D'EMIC, Susana Alves
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Diretor
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United StatesAmerican265525580001
    DAVISON, Guy Bryce
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    Diretor
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    British48717030002
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Diretor
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Diretor
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew Zealander70941240001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Diretor
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Diretor
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    MAIR, Denise Margaret
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    Diretor
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    United KingdomBritish99076200001
    MATTHEW, Michael
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    Diretor
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    British40092920001
    MAY, Stephen John
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Diretor
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish173367920001
    MEREDITH, Charles Lloyd
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Diretor
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritish189455000001
    MUNTON, Richard James
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    Diretor
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    British11882410003
    RICH, Marcus Alvin
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Diretor
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    EnglandBritish185688190001
    ROSEN, Howard Norman
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Diretor
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    UsaUsa111282190001
    WEBSTER, Evelyn Ann
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    Diretor
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    EnglandBritish68847920003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quem são as pessoas com controle significativo de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Time Uk Publishing Holdings Limited
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    04/06/2016
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalUnited Kingdom (England)
    Local de registroUnited Kingdom Companies House
    Número de registro4203872
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    Time Inc.
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    06/04/2016
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    Não
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroState Of Delaware, Usa
    Autoridade legalState Of Delaware, Usa
    Local de registroState Of Delaware, Usa
    Número de registro13-3486363
    Natureza do controle
    • A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

    TI MAGAZINES (UK) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 13/08/1999
    Entregue em 02/09/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/09/1999Registro de uma garantia (395)
    • 18/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998)
    Criado em 12/10/1998
    Entregue em 15/10/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 15/10/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/01/1998
    Entregue em 06/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of the company(formerly known as excesstop limited) to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 06/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 18/10/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0