TI MAGAZINES (UK) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | TI MAGAZINES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03483202 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
- Atividades de outras sociedades holding n.e.c. (64209) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| IPC MAGAZINES (UK) LIMITED | 03/02/1998 | 03/02/1998 |
| EXCESSTOP LIMITED | 18/12/1997 | 18/12/1997 |
Quais são as últimas contas de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2017 |
Quais são as últimas submissões para TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado do capital em 03/03/2020
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 02/03/2020
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 20/02/2018
| 8 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/12/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2018 para 30/06/2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 3rd Floor 161 Marsh Wall London E14 9AP England para 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR em 20/08/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Término da nomeação de Lauren Ezrol Klein como secretário em 31/01/2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Marcus Alvin Rich como diretor em 13/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Stephen John May como diretor em 13/03/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Joseph Henry Ceryanec como diretor em 15/02/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr John Stanley Zieser como diretor em 15/02/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Susana D'emic como diretor em 31/01/2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/12/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Alteração dos detalhes de Time Uk Publishing Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 04/06/2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Notificação de Time Inc. como pessoa com controlo significativo em 06/04/2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERYANEC, Joseph Henry | Diretor | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor England | United States | American | 243478830001 | |||||
| ZIESER, John Stanley | Diretor | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor England | United States | American | 217687580001 | |||||
| ALEY, William Robert | Secretário | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| GORE, John Francis | Secretário | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Secretário | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| LINDEN, Brian Andrew | Secretário | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | British | 36233000002 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Secretário | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Secretário | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Secretário | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALEY, William Robert | Diretor | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Diretor | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Diretor | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Diretor | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Diretor | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Diretor | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DAVISON, Guy Bryce | Diretor | 128 Kensington Park Road W1 2EP London | British | 48717030002 | ||||||
| EVANS, Richard John | Diretor | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Diretor | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Diretor | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Diretor | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||
| MAIR, Denise Margaret | Diretor | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Diretor | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Diretor | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Diretor | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| MUNTON, Richard James | Diretor | The Forge Hamptons TN11 9RE Tonbridge Kent | British | 11882410003 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Diretor | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Diretor | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 | |||||
| WEBSTER, Evelyn Ann | Diretor | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | 68847920003 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de TI MAGAZINES (UK) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Uk Publishing Holdings Limited | 04/06/2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Time Inc. | 06/04/2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
TI MAGAZINES (UK) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 13/08/1999 Entregue em 02/09/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Breve descrição .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Criado em 12/10/1998 Entregue em 15/10/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 19/01/1998 Entregue em 06/02/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities of the company(formerly known as excesstop limited) to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0