PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED

PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03483521
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Unit 1 & 2 Sawmills End
    Barnwood
    Gloucester
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais são as últimas contas de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    VencidoSim
    Próximas contas
    Próximo período contábil termina em31/12/2016
    Próximas contas vencem em30/09/2017
    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2015

    Quais são as últimas submissões para PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    4 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 24/11/2016 com atualizações

    6 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    26 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/11/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital15/12/2015

    Estado do capital em 15/12/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de Building C Imperial Gate Business Park Corinium Avenue Barnwood Gloucester GL4 3HX para Unit 1 & 2 Sawmills End Barnwood Gloucester em 02/12/2015

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    20 páginasAA

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 23/09/2015

    • Capital: GBP 5,706,466.00
    4 páginasSH01

    Estado do capital em 24/09/2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de atribuição de valores mobiliários

    RES10

    Nomeação de Mr Joseph Scott Etzler como diretor em 01/04/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Todd Brian Strubbe como diretor em 01/04/2015

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Jan Dutton Madsen como diretor em 01/03/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Paul Michael Mendlik como diretor em 01/03/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 24/11/2014 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital02/12/2014

    Estado do capital em 02/12/2014

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    19 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/11/2013 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/12/2013

    Estado do capital em 12/12/2013

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2012

    17 páginasAA

    Declaração anual preparada até 24/11/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Quem são os diretores de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MUSSMAN, David Charles
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Secretário
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    British159231890001
    BARKER, Thomas Bernard
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Diretor
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director93201870005
    BERGER, Nancee Renee
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Diretor
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director118155860002
    ETZLER, Joseph Scott
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    Diretor
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    UsaAmericanPresident197073400001
    MADSEN, Jan Dutton
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    Diretor
    Sawmills End
    Barnwood
    Unit 1 & 2
    Gloucester
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Financial Officer195930650001
    BHULLAR, Ujjal Simon
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director24910480002
    BROOK, John Anthony
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    Secretário
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    British38922990001
    SUTTON, Kirsty Jayne
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant116029280003
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretário nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BHULLAR, Amardip Singh
    4 Fern Croft
    Scarcroft
    LS14 3JN Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    4 Fern Croft
    Scarcroft
    LS14 3JN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director64136800004
    BHULLAR, Ujjal Simon
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    The Gables 1 Wigton Chase
    Alwoodley
    LS17 8SG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director24910480002
    GILLINGWATER, Geoffrey Andrew
    285 Woodfield Road
    Bilton
    HG1 4JQ Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    285 Woodfield Road
    Bilton
    HG1 4JQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishTechnical Director74374740001
    KELLY, Lee
    60 Nab Wood Road
    BD18 4AG Shipley
    Diretor
    60 Nab Wood Road
    BD18 4AG Shipley
    EnglandBritishDirector116161820001
    LINFOOT, Kevin William
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    Diretor
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector51219600001
    MAY, Neil Alistair
    Orchard Spring
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Orchard Spring
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector116016450001
    MENDLIK, Paul Michael
    Miracle Hills Drive
    68154 Omaha
    11808
    Nebraska
    Usa
    Diretor
    Miracle Hills Drive
    68154 Omaha
    11808
    Nebraska
    Usa
    UsaUsaDirector166934630001
    PATTON, Stephen Francis
    Laurel Bank
    32 Whitsbury Road
    SP6 1JZ Fordingbridge
    Hampshire
    Diretor
    Laurel Bank
    32 Whitsbury Road
    SP6 1JZ Fordingbridge
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director109947090001
    PICKETS, Gavin
    41 Old Pasture Road
    Frimley
    GU16 5RT Camberley
    Surrey
    Diretor
    41 Old Pasture Road
    Frimley
    GU16 5RT Camberley
    Surrey
    BritishSales70978960001
    RAWLES, Graham Alan
    80 Robin Hood Way
    RG41 5JN Winnersh
    Berkshire
    Diretor
    80 Robin Hood Way
    RG41 5JN Winnersh
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director97834150001
    ROBINSON, Niklas Robert
    3 Ullswater Drive
    LS22 6YF Wetherby
    West Yorkshire
    Diretor
    3 Ullswater Drive
    LS22 6YF Wetherby
    West Yorkshire
    EnglishOperations Director52615960001
    SMALLPAGE, Paul
    Maryland House 5 Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    2
    United Kingdom
    Diretor
    Maryland House 5 Grosvenor Road
    LS6 2DZ Leeds
    2
    United Kingdom
    BritishSales Director131580370001
    STRUBBE, Todd Brian
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    Diretor
    Miracle Hills Drive
    Omaha
    11808
    Nebraska 68154
    Usa
    UsaAmericanCompany Director159232530001
    SUTTON, Kirsty Jayne
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    8 The Beeches
    Pool In Wharfedale
    LS20 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant116029280003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Diretor nomeado
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Quem são as pessoas com controle significativo de PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Sawmills End
    Barnwood
    GL4 3DL Gloucester
    Unit 1 & 2
    United Kingdom
    06/04/2016
    Sawmills End
    Barnwood
    GL4 3DL Gloucester
    Unit 1 & 2
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act
    Local de registroCompanies House
    Número de registro02775270
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    PREFERRED ONE STOP TECHNOLOGIES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Charge of deposit
    Criado em 01/08/2006
    Entregue em 16/08/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The deposit initially of £200,000 credited to account designation number 33565147 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 16/08/2006Registro de uma garantia (395)
    • 11/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Criado em 06/07/2006
    Entregue em 21/07/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from dwco 6 limited to the outgoing vendors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Ujjal Simon Bhullar
    Transações
    • 21/07/2006Registro de uma garantia (395)
    • 16/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 06/07/2006
    Entregue em 18/07/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transações
    • 18/07/2006Registro de uma garantia (395)
    • 11/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Criado em 20/02/2001
    Entregue em 24/02/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed and the lease dated 9TH december 1998 (as defined)
    Breve descrição
    A first equitable charge over the deposit balance (as defined) of £5750 paid into the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • St.Martins Property Investments Limited
    Transações
    • 24/02/2001Registro de uma garantia (395)
    • 16/12/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Criado em 23/11/1999
    Entregue em 06/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 06/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 17/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0