NPS (UK5) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaNPS (UK5) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03495019
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de NPS (UK5) LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica NPS (UK5) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de NPS (UK5) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    NORTHGATE PUBLIC SECTOR LIMITED28/11/200828/11/2008
    ANITE PUBLIC SECTOR LIMITED02/02/200002/02/2000
    IMASYS LIMITED16/02/199816/02/1998
    IMASYS (LOCAL GOVERNMENT) LIMITED14/01/199814/01/1998

    Quais são as últimas contas de NPS (UK5) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/04/2018

    Quais são as últimas submissões para NPS (UK5) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW para 15 Canada Square London E14 5GL em 03/07/2019

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 10/06/2019

    LRESSP

    Declaração de confirmação apresentada em 26/11/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas de micro-entidade preparadas até 30/04/2018

    2 páginasAA

    Exercício contabilístico atual encurtado de 30/04/2019 para 31/03/2019

    1 páginasAA01

    Término da nomeação de Ian Michael Noble como diretor em 06/08/2018

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Stephen James Callaghan em 06/08/2018

    2 páginasCH01

    Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 30/04/2017

    8 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 26/11/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2016

    5 páginasAA

    Nomeação de Ian Michael Noble como diretor em 06/12/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Andrew Coll como diretor em 06/12/2016

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 26/11/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Nomeação de Mr Stephen James Callaghan como diretor em 10/10/2016

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David John Meaden como diretor em 10/10/2016

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2015

    5 páginasAA

    Declaração anual preparada até 26/11/2015 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital04/01/2016

    Estado do capital em 04/01/2016

    • Capital: GBP 61,686,134.332
    SH01

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed northgate public sector LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 páginasCERTNM
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name16/06/2015

    Alteração do nome" por resolução

    NM01
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2014

    5 páginasAA

    Satisfação total da garantia 11

    4 páginasMR04

    legacy

    páginasANNOTATION

    Quem são os diretores de NPS (UK5) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Secretário
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Secretário
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Secretário
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Secretário
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    Secretário
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretário
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHAH, Bijal
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    Secretário
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    British116421860001
    TIDSALL, David Peter Charles
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    Secretário
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    British3854790001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Secretário
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretário nomeado
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Diretor
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Diretor
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish97291590001
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Diretor
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish93657140001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Diretor
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Diretor
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    United KingdomBritish32877720003
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Diretor
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    KINGSWOOD, Michael
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    Diretor
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    British123863990001
    MARRISON, Michael Anthony
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Diretor
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish67938980003
    MCCANN, James
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Diretor
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    British69923680001
    MEADEN, David John
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Diretor
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Diretor
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    SLOGGETT, David Raymond, Dr
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    Diretor
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    British34112730001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Diretor
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Diretor
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Diretor
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Diretor
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    WOOTTON BEARD, Timothy
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    Diretor
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    British93274500001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Diretor nomeado
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Quem são as pessoas com controle significativo de NPS (UK5) LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridade legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Local de registroCompanies House
    Número de registro06526803
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    NPS (UK5) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of accession
    Criado em 27/02/2009
    Entregue em 09/03/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transações
    • 09/03/2009Registro de uma garantia (395)
    • 09/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Criado em 16/02/2007
    Entregue em 01/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/03/2007Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Criado em 15/02/2007
    Entregue em 01/03/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 01/03/2007Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 28/11/2006
    Entregue em 30/11/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 30/11/2006Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Criado em 28/02/2006
    Entregue em 02/03/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 02/03/2006Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of deposit
    Criado em 18/12/2003
    Entregue em 19/12/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The deposit.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 19/12/2003Registro de uma garantia (395)
    • 23/07/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Criado em 09/12/2002
    Entregue em 13/12/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 13/12/2002Registro de uma garantia (395)
    • 31/10/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Criado em 10/05/2002
    Entregue em 24/05/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transações
    • 24/05/2002Registro de uma garantia (395)
    • 04/07/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Criado em 08/12/2000
    Entregue em 21/12/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Breve descrição
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 21/12/2000Registro de uma garantia (395)
    • 23/05/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Criado em 09/04/1999
    Entregue em 21/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 21/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 10/04/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 30/01/1998
    Entregue em 10/02/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 10/02/1998Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2002Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 04/07/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    NPS (UK5) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    10/06/2019Início da liquidação
    02/10/2020Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0