PHEASANT CLOTHING LIMITED

PHEASANT CLOTHING LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPHEASANT CLOTHING LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03504842
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PHEASANT CLOTHING LIMITED?

    • Venda a retalho de vestuário em estabelecimentos especializados (47710) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

    Onde fica PHEASANT CLOTHING LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PHEASANT CLOTHING LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    JACK WILLS LIMITED25/06/199825/06/1998
    PRM WILLIAMS CLOTHING LIMITED05/02/199805/02/1998

    Quais são as últimas contas de PHEASANT CLOTHING LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até28/01/2018

    Quais são as últimas submissões para PHEASANT CLOTHING LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Declaração de bens vacantes

    1 páginasBONA

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Relatório de progresso do administrador

    26 páginasAM10

    Aviso de mudança da administração para dissolução

    26 páginasAM23

    Relatório de progresso do administrador

    22 páginasAM10

    Endereço do domicílio registado alterado de 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL para 10 Fleet Place London EC4M 7QS em 04/01/2022

    2 páginasAD01

    Nomeação de um administrador

    3 páginasAM01

    Aviso da aprovação presumida das propostas

    3 páginasAM06

    Declaração de proposta do administrador

    44 páginasAM03

    Relatório de progresso do administrador

    25 páginasAM10

    Aviso de término automático da administração

    25 páginasAM20

    Relatório de progresso do administrador

    23 páginasAM10

    Relatório de progresso do administrador

    25 páginasAM10

    Aviso de extensão do período da administração

    3 páginasAM19

    Relatório de progresso do administrador

    29 páginasAM10

    Aviso da aprovação presumida das propostas

    3 páginasAM06

    Endereço do domicílio registado alterado de 95 Victoria Road London NW10 6DJ England para 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL em 09/09/2019

    2 páginasAD01

    Declaração de negócios com formulário AM02SOA

    20 páginasAM02

    Declaração de proposta do administrador

    56 páginasAM03

    Nomeação de um administrador

    3 páginasAM01

    Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 035048420016

    5 páginasMR05

    Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 035048420020

    5 páginasMR05

    Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 035048420021

    5 páginasMR05

    Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 035048420018

    5 páginasMR05

    Parte do bem ou empresa foi libertada e já não faz parte da garantia 035048420019

    5 páginasMR05

    Quem são os diretores de PHEASANT CLOTHING LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    DAY, Sarah Jane
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Diretor
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritishHr Director215176060001
    HARLOW, Suzanne Marie
    95 Victoria Road
    NW10 6DJ London
    Jack Wills
    England
    Diretor
    95 Victoria Road
    NW10 6DJ London
    Jack Wills
    England
    EnglandBritishDirector245997740002
    GREINER, Fiona Louise
    185 Richmond Road
    KT2 5DD Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretário
    185 Richmond Road
    KT2 5DD Kingston Upon Thames
    Surrey
    BritishAccountant168211780001
    SHAW, Robert Wedgwood
    Manor Farm House
    East Dean
    PO18 0JA Chichester
    West Sussex
    Secretário
    Manor Farm House
    East Dean
    PO18 0JA Chichester
    West Sussex
    BritishMarketing Consultant56694940003
    WOOLF, Paul Antony
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    Secretário
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    160679860001
    ALEXANDER, Emma Rose
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishChief Product Officer196985940001
    BECKER, Wendy Mira
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    United Kingdom
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    United Kingdom
    United KingdomUsaChief Operating Officer172240510001
    DAY, Sarah Jane
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishHr Director215176060002
    DOYLE, Michael Christopher
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishCompany Director138725480003
    EVANS, Tom
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    Diretor
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    United KingdomBritishDirector157956880001
    FELTHAM, Helena Joan
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    Diretor
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    United KingdomBritishDirector152831510001
    GREINER, Fiona Louise
    185 Richmond Road
    KT2 5DD Kingston Upon Thames
    Surrey
    Diretor
    185 Richmond Road
    KT2 5DD Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishAccountant168211780001
    HOBHOUSE, William Arthur
    The Old Rectory
    Church Lane
    WD3 6HJ Sarratt
    Hertfordshire
    Diretor
    The Old Rectory
    Church Lane
    WD3 6HJ Sarratt
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector154251580001
    HOLME, Sarah Jane
    Cyprus Street
    E2 0NN London
    116
    Diretor
    Cyprus Street
    E2 0NN London
    116
    EnglandBritishDesign Director128581200001
    JOHNSON, Alan Edward
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishGlobal Retail Director197005620001
    JOHNSON, Ian Paul
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant191926380001
    MICKLER, Philip Graeme
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishCfo148159690001
    NEARY, Sophie Louise
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    Diretor
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    EnglandEnglishChief Customer Officer112451590001
    NICOLL, Richard
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishCreative Director196985730001
    PATTEN, Timothy Mark Macdougall
    Peninsula Square
    SO23 8GJ Winchester
    6
    Hampshire
    Diretor
    Peninsula Square
    SO23 8GJ Winchester
    6
    Hampshire
    EnglandBritishRetailer147946600001
    ROBERTS, Gregory Neil
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishWholesale Director240384530001
    SAUNDERS, Peter Bryce
    4841 Keswick Way
    Naples
    Florida 34105
    United States
    Diretor
    4841 Keswick Way
    Naples
    Florida 34105
    United States
    United StatesCanadianBoard Member136308180001
    SHAW, Ian
    4 Silver Street
    Minety
    SN16 9QU Malmesbury
    Wiltshire
    Diretor
    4 Silver Street
    Minety
    SN16 9QU Malmesbury
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector119278700001
    SHAW, Joanna Thomasine
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishArtist196985950001
    SHAW, Robert Wedgwood
    Manor Farm House
    East Dean
    PO18 0JA Chichester
    West Sussex
    Diretor
    Manor Farm House
    East Dean
    PO18 0JA Chichester
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director56694940003
    SHELLER, Emma Louise Camac
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandAustralianChief Marketing Officer196985850001
    TATE, Emily Sarah
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    United Kingdom
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    United Kingdom
    UkBritishChief Financial Officer160404330001
    TINTON, Glen
    26 Old Holt Road, Medbourne
    LE16 8DY Market Harborough
    Jasmine House
    Leicestershire
    Uk
    Diretor
    26 Old Holt Road, Medbourne
    LE16 8DY Market Harborough
    Jasmine House
    Leicestershire
    Uk
    EnglandBritishSourcing Director130944070001
    TURNER, Simon Eric Hugh
    Flat 5
    48 Chepstow Villas
    W11 2Q7 London
    Diretor
    Flat 5
    48 Chepstow Villas
    W11 2Q7 London
    United KingdomBritishInvestment47879840002
    WAUGH, Claire Anne
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishChief Marketing Officer239182850001
    WERTHEIM, David Martin
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishMerchandising Director239183050001
    WILLIAMS, Laura Jane
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    Diretor
    Victoria Road
    NW10 6DJ London
    95
    England
    EnglandBritishHousewife196985930001
    WILLIAMS, Peter Richard Michael
    22 Fore Street
    TQ8 8ET Salcombe
    Devon
    Diretor
    22 Fore Street
    TQ8 8ET Salcombe
    Devon
    EnglandBritishCompany Director148078820001
    WOOD, Thomas William
    Ground Floor Flat
    76 Cromford Road
    SW18 1NY London
    Diretor
    Ground Floor Flat
    76 Cromford Road
    SW18 1NY London
    EnglandBritishDirector119368670001
    WOOLF, Paul Antony
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    Diretor
    22 Fore Street
    Salcombe
    TQ8 8ET Devon
    United KingdomBritishDirector160679880001

    Quem são as pessoas com controle significativo de PHEASANT CLOTHING LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Fore Street
    TQ8 8ET Salcombe
    22
    England
    06/04/2016
    Fore Street
    TQ8 8ET Salcombe
    22
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro07121485
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    PHEASANT CLOTHING LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 12/02/2019
    Entregue em 19/02/2019
    Pendente
    Breve descrição
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 19/02/2019Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 08/02/2019
    Entregue em 12/02/2019
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Union Lifestyle Holdings Limited
    Transações
    • 12/02/2019Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 08/02/2019
    Entregue em 12/02/2019
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Union Lifestyle Holdings Limited
    Transações
    • 12/02/2019Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 25/01/2019
    Entregue em 13/02/2019
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Ggg S.P.A
    Transações
    • 13/02/2019Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 25/01/2019
    Entregue em 13/02/2019
    Pendente
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Marco Capello
    Transações
    • 13/02/2019Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 25/01/2019
    Entregue em 04/02/2019
    Pendente
    Breve descrição
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time, including UK trade mark ‘give up the suit live the life’, registration number UK00002204967 and the intellectual property listed at part vi schedule 2.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transações
    • 04/02/2019Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 30/03/2015
    Entregue em 01/04/2015
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    All of the shares of capital stock of jack wills, inc. (Delaware – 4617452)(“jwi”), now or at any time or times hereafter owned by jack wills limited (company number 03504842)(“jwl”) or held beneficially for jwl during the term of the pledge agreement dated 30 march 2015 (“the pledge agreement”), and the certificates representing the shares of such capital stock, all options and warrants for the purchase of shares of the capital stock of jwi now or hereafter held in the name of jwl or held beneficially for jwl during the term of the pledge agreement, and all dividends, cash, instruments and other property from time to time received, receivable or otherwise distributed in respect of, or in exchange for, any or all of the pledged stock, pursuant to the pledge agreement.
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 01/04/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 08/05/2014
    Entregue em 23/05/2014
    Totalmente satisfeita
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Inflexion Private Equity Partners LLP as Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transações
    • 23/05/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 20/02/2015Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 25/10/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 08/05/2014
    Entregue em 15/05/2014
    Pendente
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over all property and assets of the company.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 15/05/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/08/2019Parte do imóvel ou empresa foi liberada e não mais faz parte da garantia (MR05)
    A registered charge
    Criado em 02/08/2013
    Entregue em 05/08/2013
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Inflexion Private Equity Partners LLP as Security Trustee
    Transações
    • 05/08/2013Registro de uma garantia (MR01)
    • 19/03/2015Todo o imóvel ou empresa foi liberado da garantia (MR05)
    • 25/10/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Guarantee & debenture
    Criado em 18/04/2012
    Entregue em 02/05/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and all the other companies and limited liability partnerships to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 02/05/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 13/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 15/12/2009
    Entregue em 19/12/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £23,808.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All sums held on behalf of the landlord full title guarantee charges interest see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bicester Nominees Limited & Bicester Ii Nominees Limited
    Transações
    • 19/12/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 24/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 23/03/2009
    Entregue em 26/03/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The amount outstanding to the credit a separate designated deposit account with the chargees bankers.
    Pessoas com direito
    • A Brooks Properties
    Transações
    • 26/03/2009Registro de uma garantia (395)
    • 27/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 29/10/2008
    Entregue em 13/11/2008
    Pendente
    Montante garantido
    £15,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    All those sums from time to time in the deposit account see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Bicester Nominees Limited and Bicester Ii Nominees Limited
    Transações
    • 13/11/2008Registro de uma garantia (395)
    Rent deposit deed
    Criado em 23/08/2006
    Entregue em 25/08/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The initial deposit together with any interest and any monies.
    Pessoas com direito
    • Andrew Douglas Brownsword
    Transações
    • 25/08/2006Registro de uma garantia (395)
    • 27/07/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 17/07/2006
    Entregue em 26/07/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 26/07/2006Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit
    Criado em 16/06/2006
    Entregue em 22/06/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Brixton (Chase Road/Oakwood) 1 Limited
    Transações
    • 22/06/2006Registro de uma garantia (395)
    • 24/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 20/05/2005
    Entregue em 24/05/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The tenants interest in all the monies standing to the credit of the account including all interest accruing thereto.
    Pessoas com direito
    • UK Investments Limited
    Transações
    • 24/05/2005Registro de uma garantia (395)
    • 12/09/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 07/06/2004
    Entregue em 08/06/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Hsbc Bank PLC
    Transações
    • 08/06/2004Registro de uma garantia (395)
    • 17/07/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/03/2004
    Entregue em 31/03/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Sme Invoice Finance Limited
    Transações
    • 31/03/2004Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 26/11/2001
    Entregue em 29/11/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 29/11/2001Registro de uma garantia (395)
    • 02/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    PHEASANT CLOTHING LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    05/08/2019Início da administração
    04/08/2020Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Christopher Robert Pole
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    2
    DataTipo
    05/08/2020Início da administração
    03/08/2022Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Christopher Robert Pole
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profissional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0