CUESIM LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | CUESIM LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03513912 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de CUESIM LIMITED?
- Atividades de consultoria em tecnologia da informação (62020) / Informação e comunicação
Onde fica CUESIM LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | FRP ADVISORY TRADING LIMITED Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de CUESIM LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MOTIONBASE LIMITED | 05/06/2002 | 05/06/2002 |
| MOTIONBASE PLC | 21/05/2002 | 21/05/2002 |
| MOTIONBASE PLC | 17/02/1998 | 17/02/1998 |
Quais são as últimas contas de CUESIM LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para CUESIM LIMITED?
| Última declaração de confirmação | |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 11/01/2024 |
Quais são as últimas submissões para CUESIM LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Cody Technology Park Ively Road Farnborough Hampshire GU14 0LX para Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ em 23/12/2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaração de solvência | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Estado do capital em 12/03/2024
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/01/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2023 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para James Stephen Field em 17/04/2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/01/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2022 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de James Stephen Field como secretário em 11/08/2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Término da nomeação de Christopher John Walker como diretor em 11/08/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jon Messent como diretor em 11/08/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Sandra Gillian Anne Tizzard como diretor em 11/08/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jon Messent como secretário em 11/08/2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nomeação de James Stephen Field como diretor em 11/08/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Heather Anne Cashin como diretor em 11/08/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/01/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2021 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/01/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Quem são os diretores de CUESIM LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD, James Stephen | Secretário | Queen Street BS2 0HQ Bristol Kings Orchard 1 | 300568940001 | |||||||
| CASHIN, Heather Anne | Diretor | Queen Street BS2 0HQ Bristol Kings Orchard 1 | England | British | 298988210001 | |||||
| FIELD, James Stephen | Diretor | Queen Street BS2 0HQ Bristol Kings Orchard 1 | England | British | 298479420002 | |||||
| BOARDMAN, Lynton David | Secretário | Cherwell Forest Drive KT20 6LU Kingswood Surrey | British | 72633900005 | ||||||
| MESSENT, Jon | Secretário | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | British | 157180380001 | ||||||
| THODY, Elizabeth | Secretário | Ventnor 46 Chertsy Road GU20 6EP Windlesham Surrey | British | 80499670001 | ||||||
| QUAYSECO LIMITED | Secretário | Narrow Quay House Narrow Quay BS1 4AH Bristol | 50174700001 | |||||||
| ADCOCK, Miles John, Dr | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | England | British | 177091950001 | |||||
| ANDERSON, David Alexander, Doctor | Diretor | 14 Napier Gardens GU1 2PG Guildford Surrey | British | 73725160001 | ||||||
| BEVAN, Neil Richard | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | England | British | 131021400001 | |||||
| BIRKETT, Peter Ronald | Diretor | 64 Salisbury Road GU14 7AG Farnborough Hampshire | United Kingdom | British | 120275420001 | |||||
| BUTCHER, Mark Raymond | Diretor | 14 Grasmere Close Merrow GU1 2TG Guildford Surrey | England | British | 80623690001 | |||||
| CARVER, Mary Kathleen | Diretor | Buckingham Gate SW1E 6PD London 85 | United Kingdom | British | 109959200001 | |||||
| COPPARD, Robert William, Dr | Diretor | 2 Pennington Close Colden Common SO21 1UR Winchester Hampshire | England | British | 115214260001 | |||||
| DANBURY, Richard | Diretor | Bramble Cottage Rectory Lane BS40 6JP Compton Martin Bristol | British | 56658210002 | ||||||
| FIELD, James Stephen | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | 173955310001 | |||||
| GARROD, Michael James Baring | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 224052010001 | |||||
| GILLBE, Ivor Stephen | Diretor | Greensleeves Bridge Road Leigh Woods BS8 3PE Bristol Avon | England | British | 21171630002 | |||||
| JACKSON, Steven William | Diretor | Mead Way Harrold MK43 7DP Bedford 3 Bedfordshire | England | British | 128161390001 | |||||
| JENKINS, Peter John | Diretor | Barn Owl Cottage Daisy Green Great Ashfield IP31 3HX Bury St. Edmunds Suffolk | England | British | 100266410001 | |||||
| KNIGHT, Andre Peter | Diretor | 22 Penrose Way Four Marks GU34 5BG Alton Hampshire | British | 76291450001 | ||||||
| LING, Christopher Adam | Diretor | Buckingham Gate SW1E 6PD London 85 | England | British | 65865520001 | |||||
| MAYCROFT, Hassina | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | 173955560001 | |||||
| MESSENT, Jon | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 157179420002 | |||||
| O'CONNOR, Michael Victor | Diretor | Elmbridge Drive Shirley B90 4YP Solihull 22 West Midlands England | United Kingdom | British | 127992780002 | |||||
| RAZDAN, Sanjay | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | England | Canadian | 165471790001 | |||||
| READ, Paul Robert | Diretor | 3 Kingfisher Close Wheathampstead AL4 8JJ St. Albans Hertfordshire | British | 83081830001 | ||||||
| REED, Allyson Patricia Catherine, Dr | Diretor | The Gate House OX11 9HD Upton Oxon | United Kingdom | British | 118659090001 | |||||
| REID, Ian Paul | Diretor | 201 London Road Holybourne GU34 4EY Alton Hampshire | England | British | 47960750003 | |||||
| ROBINSON, Kathryn Margaret | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | England | British | 157721190001 | |||||
| SALKELD, Thomas Neville Walton | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | 152235640001 | |||||
| SHAH, Bimal | Diretor | Sandridge Road AL1 4AJ St. Albans 262 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 132307250001 | |||||
| TIZZARD, Sandra Gillian Anne | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | 263449070001 | |||||
| WALKER, Christopher John | Diretor | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | United Kingdom | British | 224224450001 | |||||
| WALL, Anthony John | Diretor | Two & A Half Faringdon Road, Southmoor OX13 5BH Abingdon Oxon E | England | British | 61591420004 |
Quem são as pessoas com controle significativo de CUESIM LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qinetiq Holdings Limited | 06/04/2016 | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
CUESIM LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0