CARDPOINT SERVICES LIMITED

CARDPOINT SERVICES LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCARDPOINT SERVICES LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03516589
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    c/o CARDTRONICS UK LIMITED
    Building 4, 1st Floor Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Hertfordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CARDPOINT SERVICES TRADING AS CASHZONE LIMITED19/02/200919/02/2009
    CARDPOINT SERVICES LIMITED23/10/200823/10/2008
    MONEYBOX CORPORATION LIMITED17/01/200017/01/2000
    MONEY BOX CORPORATION LIMITED25/02/199825/02/1998

    Quais são as últimas contas de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Qual é o status da última declaração anual para CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    4 páginasDS01

    Término da nomeação de Michael Edward Keller como diretor em 25/06/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de John Christopher Brewster como diretor em 25/06/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Michael Edward Keller como secretário em 25/06/2015

    1 páginasTM02

    Declaração anual preparada até 25/02/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/03/2015

    Estado do capital em 03/03/2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de C/O Squire Sanders (Uk) Llp Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR England para C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 páginasAD02

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 páginasAD03

    Nomeação de Jana Hile como diretor em 15/08/2014

    2 páginasAP01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 27/11/2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Término da nomeação de Jeremy David Kraft como diretor em 30/09/2014

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    19 páginasAA

    Endereço do domicílio registado alterado de , Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House, 148 Edmund Street, Birmingham, B3 2JR em 16/06/2014

    1 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 25/02/2014 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital25/02/2014

    Estado do capital em 25/02/2014

    • Capital: GBP 5,769,863.59
    SH01

    O endereço de inspeção do registo foi alterado de Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom

    1 páginasAD02

    Os registos foram transferidos para o endereço do domicílio registado

    1 páginasAD04

    Renúncia do auditor

    3 páginasAUD

    Nomeação de Mr Jeremy David Kraft como diretor

    2 páginasAP01

    Nomeação de Michael Keller como secretário

    3 páginasAP03

    Nomeação de John Christopher Brewster como diretor

    3 páginasAP01

    Quem são os diretores de CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    HILE, Jana
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    EnglandAustralian192111080001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    Diretor
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110396210002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secretário
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HOGAN, Brenda
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Secretário
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Other75975040003
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secretário
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Secretário
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    American105857220002
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Secretário
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretário nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Diretor
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Diretor
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BREWSTER, John Christopher
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican181428100001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    Diretor
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    DINSMORE, Rikki Gavin
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    Diretor
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    United KingdomBritish137100920001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Diretor
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Diretor
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HOLROYD, Richard Norton
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    Diretor
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    British80220410001
    ISAACS, Vincent
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    Diretor
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    British38705920001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Diretor
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican105857220002
    KRAFT, Jeremy David
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    Diretor
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish71360190003
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Diretor
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Diretor
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Diretor
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Diretor
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MORGAN, Colin John
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Diretor
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Irish70867300001
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Diretor
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Diretor
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    United KingdomBritish116252510001
    ROBSON, Vincent Martin
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    Diretor
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    British64602710001
    RYLAND, Stuart Antony
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    Diretor
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish74367340001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Diretor
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Diretor
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Diretor
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    STIMPSON, Andrew David
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    Diretor
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    EnglandBritish99393670001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Diretor
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Diretor nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    CARDPOINT SERVICES LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A confirmatory security agreement
    Criado em 09/04/2010
    Entregue em 13/04/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transações
    • 13/04/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 09/08/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    A second ranking share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Criado em 05/02/2010
    Entregue em 22/02/2010
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Existing pledges means the pledges constituted pursuant to the existing share pledge agreement, shares. The pledges include the present and future rights to receive dividends and liquidation proceeds, see image for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transações
    • 22/02/2010Registro de uma garantia (MG01)
    • 09/08/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    A security agreement
    Criado em 05/12/2007
    Entregue em 15/12/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transações
    • 15/12/2007Registro de uma garantia (395)
    • 09/08/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    Share pledge agreement
    Criado em 18/05/2007
    Entregue em 02/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The existing shares and the future shares together with all ancillary rights and claims, dividends payable in relation to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Agent or the Security Trustee). the Royalbank of Scotland the 'Original Pledgees'
    Transações
    • 02/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 20/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Syndicated debenture
    Criado em 13/03/2006
    Entregue em 22/03/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    01. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustees for Thebeneficiaries
    Transações
    • 22/03/2006Registro de uma garantia (395)
    • 20/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Criado em 19/12/2005
    Entregue em 06/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transações
    • 06/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 20/12/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 12/07/2005
    Entregue em 15/07/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transações
    • 15/07/2005Registro de uma garantia (395)
    • 21/10/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/09/2004
    Entregue em 09/09/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 09/09/2004Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 01/09/2004
    Entregue em 03/09/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 03/09/2004Registro de uma garantia (395)
    • 30/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Chattels mortgage
    Criado em 03/06/2003
    Entregue em 21/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,100,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    52 authomated teller machines.
    Pessoas com direito
    • Abbey National PLC
    Transações
    • 21/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 03/04/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Mortgage of chattels
    Criado em 03/06/2003
    Entregue em 19/06/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A number of automated teller machines situated at the locations together with the benefit of a licence to retain the atms at the locations. The benefit of all contracts and agreements relating to the atms. Any goodwill in the atms. The benefit of any insurances in relating to the atms.
    Pessoas com direito
    • Abbey National PLC
    Transações
    • 19/06/2003Registro de uma garantia (395)
    • 03/04/2010Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0