03566373 LTD

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresa03566373 LTD
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03566373
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de 03566373 LTD?

    • (7412) /

    Onde fica 03566373 LTD?

    Endereço do escritório registrado
    Freshford House
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de 03566373 LTD?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PASSTOR LIMITED19/05/199819/05/1998

    Quais são as últimas contas de 03566373 LTD?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2010

    Quais são as últimas submissões para 03566373 LTD?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Notificação da conta final antes da dissolução

    21 páginasWU15

    Relatório de progresso numa liquidação pelo tribunal

    19 páginasWU07

    Relatório de progresso numa liquidação pelo tribunal

    20 páginasWU07

    Relatório de progresso numa liquidação pelo tribunal

    22 páginasWU07

    Endereço do domicílio registado alterado de One Redcliff Street Bristol BS1 6NP para Freshford House Redcliffe Way Bristol BS1 6NL em 13/10/2017

    2 páginasAD01

    Pedido de insolvência

    INSOLVENCY:Progress report ends 12/01/2017
    16 páginasLIQ MISC

    Satisfação parcial da garantia 3

    4 páginasMR04

    Satisfação parcial da garantia 9

    4 páginasMR04

    Endereço do domicílio registado alterado de Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP para One Redcliff Street Bristol BS1 6NP em 03/02/2016

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidatário

    1 páginas4.31

    legacy

    3 páginasAC93

    Ordem do tribunal para liquidar

    2 páginasCOCOMP

    Certificado de mudança de nome

    Company name changed target consulting\certificate issued on 18/12/15
    páginasCERTNM

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Relatório de progresso do administrador até 25/04/2014

    13 páginas2.24B

    Aviso de mudança da administração para dissolução

    12 páginas2.35B

    Relatório de progresso do administrador até 05/04/2014

    12 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 05/10/2013

    10 páginas2.24B

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Relatório de progresso do administrador até 05/04/2013

    11 páginas2.24B

    Aviso de extensão do período da administração

    1 páginas2.31B

    Relatório de progresso do administrador até 29/10/2012

    12 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 29/10/2012

    11 páginas2.24B

    Relatório de progresso do administrador até 24/05/2012

    22 páginas2.24B

    Quem são os diretores de 03566373 LTD?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    BENNETT, Amanda Louise
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    Secretário
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    British85770530001
    BENNETT, Amanda Louise
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    Diretor
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    EnglandBritish85770530001
    HARMAN, Mark David
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    Diretor
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    EnglandBritish137945300001
    LENTHALL, Gavin Antony
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    Diretor
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    United KingdomBritish47377290001
    SANDIFORD, Andrew Philip
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    Diretor
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    EnglandBritish122009600001
    SEELEY, Keith
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    Diretor
    Redcliffe Way
    BS1 6NL Bristol
    Freshford House
    United KingdomBritish84367450004
    COOK, Sarah
    10 Drynham Road
    BA14 0PE Trowbridge
    Wiltshire
    Secretário
    10 Drynham Road
    BA14 0PE Trowbridge
    Wiltshire
    British84682100001
    HARMAN, Mark David
    4 Rode Hill
    Rode
    BA11 6PT Frome
    Windrush
    Somerset
    Secretário
    4 Rode Hill
    Rode
    BA11 6PT Frome
    Windrush
    Somerset
    British59169960001
    LENTHALL, Gavin Antony
    Flat 1
    54 Hampton Park
    BS6 6LJ Bristol
    Avon
    Secretário
    Flat 1
    54 Hampton Park
    BS6 6LJ Bristol
    Avon
    British47377290001
    WALSH, Robert Daniel
    Vine Cottage
    76 Carlingcott
    BA2 8AP Peasedown St John
    Bath
    Secretário
    Vine Cottage
    76 Carlingcott
    BA2 8AP Peasedown St John
    Bath
    British60752980001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, Anthony
    37 Randall Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AJ Eastleigh
    Hampshire
    Diretor
    37 Randall Road
    Chandlers Ford
    SO53 5AJ Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritish142063890001
    GARDNER, John
    7 Meathop Grange
    Meathop
    LA11 6RB Grange Over Sands
    Cumbria
    Diretor
    7 Meathop Grange
    Meathop
    LA11 6RB Grange Over Sands
    Cumbria
    EnglandBritish103822010001
    GRIFFITHS, Martin William
    15 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QF Bristol
    Diretor
    15 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QF Bristol
    British52265300003
    HELLEN, Joanna Elisabeth Alexandra
    7 Surrey Road
    Bishopston
    BS7 9DJ Bristol
    Diretor
    7 Surrey Road
    Bishopston
    BS7 9DJ Bristol
    British86789450001
    PALMER, Adrian Russell
    19 Royal Crescent
    BA1 2LT Bath
    Diretor
    19 Royal Crescent
    BA1 2LT Bath
    British101374620002
    ROLFE, Jonathan Sholto
    Roseland Close
    Solsbury Court
    BA1 7AD Bath
    4
    Somerset
    Diretor
    Roseland Close
    Solsbury Court
    BA1 7AD Bath
    4
    Somerset
    United KingdomBritish141653930001
    SKEDD, Alison Jane
    Cote House
    Upper Wraxall
    SN14 7AG Chippenham
    Wilts
    Diretor
    Cote House
    Upper Wraxall
    SN14 7AG Chippenham
    Wilts
    EnglandBritish113208220001
    SWIFT, Anthony Hugh
    Horsecombe Grange Horsecombe Vale
    BA2 5QR Bath
    Diretor
    Horsecombe Grange Horsecombe Vale
    BA2 5QR Bath
    EnglandBritish36361530003
    WOODCOCK, Thomas
    7 Holcombe Lane
    Bathampton
    BA2 6UL Bath
    Diretor
    7 Holcombe Lane
    Bathampton
    BA2 6UL Bath
    British74559910001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    03566373 LTD possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 04/07/2011
    Entregue em 22/07/2011
    Parcialmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 22/07/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 03/12/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 07/12/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 13/12/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 29/09/2016Satisfação parcial de um encargo (MR04)
    Rent deposit deed
    Criado em 04/04/2011
    Entregue em 07/04/2011
    Pendente
    Montante garantido
    £25,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Rent deposit only.
    Pessoas com direito
    • Itochu Europe PLC
    Transações
    • 07/04/2011Registro de uma garantia (MG01)
    Debenture
    Criado em 31/12/2005
    Entregue em 07/01/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    £626,000 and all other monies due or to become due
    Breve descrição
    All f/h and l/h property together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery,all goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Hugh Reginald Patrick Thompson,Ian Melvyn Barrie,Richard Player Grain and Martin David Reidshave
    Transações
    • 07/01/2006Registro de uma garantia (395)
    • 11/02/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/03/2005
    Entregue em 09/04/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Richard John Rand, Julian Paul Pearce, Robert Nicholas Pittman and Pauline Mary Copestake
    Transações
    • 09/04/2005Registro de uma garantia (395)
    • 26/08/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 01/11/2002
    Entregue em 07/11/2002
    Parcialmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/11/2002Registro de uma garantia (395)
    • 03/12/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 07/12/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 13/12/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 29/09/2016Satisfação parcial de um encargo (MR04)
    Charge over deposits
    Criado em 21/02/2001
    Entregue em 01/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    First fixed charge over any sums deposited in any deposit account.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transações
    • 01/03/2001Registro de uma garantia (395)
    • 02/11/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 21/02/2001
    Entregue em 23/02/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transações
    • 23/02/2001Registro de uma garantia (395)
    • 02/11/2002Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    03566373 LTD possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    25/11/2011Início da administração
    02/05/2014Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Jonathan Hunt
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    2
    DataTipo
    15/06/2020Conclusão da liquidação
    31/07/2015Data da petição
    03/11/2015Início da liquidação
    05/12/2020Data de dissolução
    Liquidação compulsória
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Simon Ashley Rowe
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    Profissional
    One Redcliff Street
    BS1 6NP Bristol
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profissional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0