TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED

TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaTRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03592155
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1 Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    TRADER MEDIA CORPORATION LIMITED15/06/200015/06/2000
    HURST CORPORATION LIMITED03/07/199803/07/1998
    HURST NEWCO 4 LIMITED29/06/199829/06/1998

    Quais são as últimas contas de TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até29/03/2015

    Quais são as últimas submissões para TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginas4.71

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 24/03/2016

    LRESSP

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Término da nomeação de Trevor Nigel Mather como diretor em 18/03/2016

    1 páginasTM01

    Estado do capital em 03/02/2016

    • Capital: GBP 100.1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share premium account 15/01/2016
    RES13

    Satisfação total da garantia 035921550007

    1 páginasMR04

    Contas anuais preparadas até 29/03/2015

    12 páginasAA

    Memorando e estatutos

    9 páginasMA

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Declaração anual preparada até 20/05/2015 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital28/05/2015

    Estado do capital em 28/05/2015

    • Capital: GBP 100.1
    SH01

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01

    Registo da garantia 035921550007, criada em 15/04/2015

    31 páginasMR01

    Satisfação total da garantia 035921550006

    1 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 4

    2 páginasMR04

    Satisfação total da garantia 5

    1 páginasMR04

    Detalhes do diretor alterados para Mr Trevor Nigel Mather em 17/03/2015

    2 páginasCH01

    Detalhes do secretário alterados para Mr Sean Glithero em 17/03/2015

    1 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Mr Sean Robert Glithero em 17/03/2015

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT para 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN em 23/12/2014

    1 páginasAD01

    Contas consolidadas preparadas até 30/03/2014

    40 páginasAA

    Quem são os diretores de TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GLITHERO, Sean
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Secretário
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    159906130001
    GLITHERO, Sean Robert
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Diretor
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish129229070002
    SOMERSET, Ian
    M15 4FN Manchester
    Number 1 First Street
    Lancashire
    United Kingdom
    Diretor
    M15 4FN Manchester
    Number 1 First Street
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish191225040001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Secretário
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    British15959630001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Secretário
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Secretário
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    JENKIN, Elizabeth
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretário
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    British137518870001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secretário
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secretário
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Secretário
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    United Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Secretário
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    Diretor
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United KingdomBritish147214630001
    CASTRO, Nicholas
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    Diretor
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    EnglandBritish39006500001
    COLLET, Tara
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    Diretor
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish160951420001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Diretor
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Diretor
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    KING, John Robert
    Tresspassers
    Knowle Hill
    GU25 4HZ Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Tresspassers
    Knowle Hill
    GU25 4HZ Virginia Water
    Surrey
    Australian126634830001
    LANE, Stephen John Roger
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    Diretor
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    EnglandBritish123670600001
    LUFF, Graham Ewart
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    British46555440002
    MATHER, Trevor Nigel
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Diretor
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish83431330001
    MCCALL, Carolyn Julia
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Diretor
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British39252480010
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Diretor
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritish162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Diretor
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Diretor
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    STOREY, Graham Neil
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    Diretor
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish48939070004

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 15/04/2015
    Entregue em 20/04/2015
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust (London) Limited and Its Successors in Title and Permitted Transferees
    Transações
    • 20/04/2015Registro de uma garantia (MR01)
    • 08/01/2016Satisfação de uma garantia (MR04)
    A registered charge
    Criado em 28/02/2014
    Entregue em 04/03/2014
    Totalmente satisfeita
    Breve descrição
    Trademarks and domain names being trader media (words only) trader media group (words only) trader media group (image) 8 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Wilmington Trust (London) Limited (and Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transações
    • 04/03/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 25/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Fixed and floating security document
    Criado em 20/06/2011
    Entregue em 07/07/2011
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transações
    • 07/07/2011Registro de uma garantia (MG01)
    • 25/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 08/06/2007
    Entregue em 14/06/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • J.P.Morgan Europe Limtied as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transações
    • 14/06/2007Registro de uma garantia (395)
    • 17/11/2009Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 25/03/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    Global accession deed
    Criado em 03/10/2003
    Entregue em 10/10/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transações
    • 10/10/2003Registro de uma garantia (395)
    • 01/03/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein
    Criado em 24/05/2000
    Entregue em 08/06/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag London as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transações
    • 08/06/2000Registro de uma garantia (395)
    • 11/10/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 21/07/1998
    Entregue em 07/08/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Deutsche Bank Ag London(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    Transações
    • 07/08/1998Registro de uma garantia (395)
    • 11/10/2003Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    24/03/2016Início da liquidação
    21/01/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Profissional
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profissional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0