ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03621275
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio

    Onde fica ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    PINCO 1110 LIMITED25/08/199825/08/1998

    Quais são as últimas contas de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2018

    Quais são as últimas submissões para ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2018

    17 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 14/12/2018

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium account 13/12/2018
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Resoluções

    Resolutions
    17 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de alteração dos direitos ou da designação das ações

    RES12
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Alteração do nome ou designação da classe de ações

    2 páginasSH08

    Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2018 com atualizações

    5 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017

    3 páginasAA

    Detalhes do secretário alterados para Alison Murphy em 01/11/2017

    1 páginasCH03

    Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2017 com atualizações

    5 páginasCS01

    Término da nomeação de Alison Murphy como diretor em 01/07/2017

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    3 páginasAA

    Renúncia do auditor

    1 páginasAUD

    Nomeação de Mrs Alison Murphy como diretor em 01/11/2016

    2 páginasAP01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2015

    3 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 25/08/2016 com atualizações

    6 páginasCS01

    Término da nomeação de Roy Douglas Smith como diretor em 12/08/2016

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Daniel George Darazsdi como diretor em 12/08/2016

    1 páginasTM01

    Nomeação de Alison Murphy como secretário em 12/08/2016

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Roy Douglas Smith como secretário em 12/08/2016

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    MURPHY, Alison
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    214335080001
    CLEARS, David Shaun
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Diretor
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish214322760001
    GLENNON, Stephen Matthew
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Diretor
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish88291900001
    BOWERS, Steven John
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    Secretário
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    British61929330004
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Secretário
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    British68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Secretário
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Secretário
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Secretário
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    170871450001
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Secretário
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    British39200370004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BEAUMONT, Richard John Kirby
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    Diretor
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    British98953190001
    BLATHERWICK, Nigel Ashley
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish118979720001
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Diretor
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritish176189250001
    DARAZSDI, Daniel George
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Diretor
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    UsaAmerican195049720001
    DEVAULT, Jon
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    Diretor
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    American63857020001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Diretor
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmerican170878740001
    ENGLISH, Peter David
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    Diretor
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    British3355360001
    FORD, Richard Guy
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    Diretor
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    British1467170002
    GHAVAM SHAHIDI, Ebrahim
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    Diretor
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish117846410001
    MABBITT, Jonathan Peter
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Diretor
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish83707310002
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Diretor
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Diretor
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOSS, Andrew Brian
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Diretor
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MOSS, Andrew Brian
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    Diretor
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MURPHY, Alison
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Diretor
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish111169560001
    POTTS, Hugh Adrian
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    Diretor
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    UsaBritish52210510003
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Diretor
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    SLOMAN, Roger Mark
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    Diretor
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    British8257720002
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Diretor
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsa170877010001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Diretor
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish32242700001
    STREET, Andrew John
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    Diretor
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish36056510008
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Diretor
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish39200370004
    WEIDNER, John Charles
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Diretor
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Usa74299320001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Diretor
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Umeco Limited
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    06/04/2016
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridade legalCompanies Act
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 11/12/2009
    Entregue em 30/12/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 30/12/2009Registro de uma garantia (MG01)
    • 19/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997,
    Criado em 23/11/2006
    Entregue em 29/11/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 29/11/2006Registro de uma garantia (395)
    • 19/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997
    Criado em 16/07/2004
    Entregue em 22/07/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 22/07/2004Registro de uma garantia (395)
    • 19/04/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 31/03/1999
    Entregue em 15/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Derbyshire Enterprise Board (Investments) Limited
    Transações
    • 15/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 09/05/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 31/03/1999
    Entregue em 15/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Derbyshire County Council
    Transações
    • 15/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 09/05/2000Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 31/03/1999
    Entregue em 08/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 08/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 22/02/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0