OPUS HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaOPUS HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03625614
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de OPUS HOLDINGS LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica OPUS HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de OPUS HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    HEATH UK HOLDINGS LIMITED22/10/199822/10/1998
    PALMGRIP LIMITED02/09/199802/09/1998

    Quais são as últimas contas de OPUS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2016

    Quais são as últimas submissões para OPUS HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Endereço do domicílio registado alterado de 51 Lime Street London EC3M 7DQ para 30 Finsbury Square London EC2P 2YU em 19/10/2018

    2 páginasAD01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Declaração de solvência

    5 páginasLIQ01

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 25/09/2018

    LRESSP

    legacy

    3 páginasSH20

    Estado do capital em 20/09/2018

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of the share premium account 19/09/2018
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 02/09/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Nomeação de Mrs Rosemary Hazel Hammond-West como diretor em 17/08/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Oliver Hew Wallinger Goodinge como diretor em 28/06/2018

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Mr Oliver Hew Wallinger Goodinge em 11/06/2018

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 02/09/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    5 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Oliver Hew Wallinger Goodinge em 09/07/2016

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 02/09/2016 com atualizações

    5 páginasCS01

    Término da nomeação de Alistair Charles Peel como secretário em 22/07/2016

    1 páginasTM02

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    16 páginasAA

    Nomeação de Dr Michael John Cherry como diretor em 29/01/2016

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Stephen Edward Wood como diretor em 29/01/2016

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 02/09/2015 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital29/09/2015

    Estado do capital em 29/09/2015

    • Capital: GBP 52,612
    SH01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    15 páginasAA

    Satisfação total da garantia 2

    1 páginasMR04

    Quem são os diretores de OPUS HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    CHERRY, Michael John, Dr
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritishChartered Accountant205416760001
    HAMMOND-WEST, Rosemary Hazel
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Diretor
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritishCompany Director205417960001
    WILLIS CORPORATE DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Diretor
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro5059095
    104850230002
    BAREHAM, Robert Edward
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    Secretário
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant8522090001
    BRYANT, Shaun Kevin
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    Secretário
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    BritishChartered Secretary38944420002
    PEEL, Alistair Charles
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Secretário
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    171950890001
    WARREN, Tracy Marina
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    Secretário
    Hollow Road
    Felsted
    CM6 3JF Dunmow
    The Molehill
    Essex
    United Kingdom
    British132463120001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretário nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    WILLIS CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    Secretário
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    Tipo de identificaçãoEEE
    Número de registro2923054
    154488070001
    BAREHAM, Robert Edward
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    Diretor
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant8522090001
    BRICE, Ian Charles
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    Diretor
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    BritishInsurance Broker63706880001
    BRYANT, Shaun Kevin
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    Diretor
    22 Searle Way
    Eight Ash Green
    CO6 3QS Colchester
    Essex
    United KingdomBritishChartered Secretary38944420002
    ELLEN, Simon Tudor
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Diretor
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    United KingdomBritishInvestment Banker111926600001
    GOODINGE, Oliver Hew Wallinger
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Diretor
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    United KingdomBritishLegal Counsel165971630003
    HATTERSLEY, Peter
    7 Langford Lane
    Burley In Wharfedale
    LS29 7NR Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    7 Langford Lane
    Burley In Wharfedale
    LS29 7NR Ilkley
    West Yorkshire
    BritishInsurance Broker49834650001
    KONIG, James
    38 Station Road
    BR4 0PR West Wickham
    Kent
    Diretor
    38 Station Road
    BR4 0PR West Wickham
    Kent
    BritishFinancial Advisor63706570001
    LETBY, Roger David
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    Diretor
    19 Alverton Close
    Great Notley
    CM7 8XU Braintree
    Essex
    BritishInsurance Broker28585270003
    MCCANN, Christopher Conor
    Sydney House
    10 Lonsdale Square
    N1 1EN London
    Diretor
    Sydney House
    10 Lonsdale Square
    N1 1EN London
    United KingdomBritishPrivate Equity Investor63996830001
    PEPPER, Gerald Ivan
    1 Raffin Green Lane
    Datchworth
    SG3 6RH Knebworth
    Hertfordshire
    Diretor
    1 Raffin Green Lane
    Datchworth
    SG3 6RH Knebworth
    Hertfordshire
    BritishFinancial Adviser34977410001
    TRUEMAN, John Francis
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Diretor
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    United KingdomBritishMerchant Banker100995990002
    WHITEHEAD, John William
    24 Raeden Avenue
    AB2 4LP Aberdeen
    Diretor
    24 Raeden Avenue
    AB2 4LP Aberdeen
    BritishInsurance Broker51010001
    WOOD, Stephen Edward
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Diretor
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    United KingdomBritishFinance Controller63994990001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Diretor nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    WILLIS CORPORATE DIRECTOR SERVICES LIMITED
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Diretor
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    104850230002
    WILLIS CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    Diretor
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    104850580002

    Quem são as pessoas com controle significativo de OPUS HOLDINGS LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Willis Faber Limited
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    06/04/2016
    Lime Street
    EC3M 7DQ London
    51
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroEngland
    Número de registro01386469
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    OPUS HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Rent deposit deed
    Criado em 16/07/2002
    Entregue em 18/07/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    A rent deposit of £10,575.
    Pessoas com direito
    • Universal Consolidated Ventures Limited
    Transações
    • 18/07/2002Registro de uma garantia (395)
    • 20/10/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14 february 2000 and dated
    Criado em 11/02/2000
    Entregue em 19/02/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the finance parties directly or indirectly under or pursuant tothe terms of any of the finance documents and/or in connection with any loan facility of other financial accomodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto
    Breve descrição
    All and whole that piece of ground along the north side of carden place in the city parish of aberdeen and county of aberdeen, see form 395 for further details of property. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee (Or Such Other Person as May Be Appointed)
    Transações
    • 19/02/2000Registro de uma garantia (395)
    • 20/10/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 1 april 1999 and
    Criado em 22/10/1998
    Entregue em 21/04/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly k/a palmgrip limited to the chargee or any of the finance parties (as defined) under or pursuant to the terms of the finance documents and/or any loan facility or toehr financial accommodation
    Breve descrição
    Land consisting of one and one third garden roods bounded by lindsay lane on the north in burgh of brechin county of angus together with buildings thereon forming 1B clerk street brechin.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The Security Trustee)
    Transações
    • 21/04/1999Registro de uma garantia (395)
    • 20/10/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Criado em 22/10/1998
    Entregue em 11/11/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company (formerly known as palmgrip limited) to the chargee or any of the secured parties (as defined) or any of them including all monies obligations and liabilities under or pursuant to the secured documents (as defined); and all monies and liabilities due or to become due from each other company to the chargee or the secured parties under or pursuant to the secured documents (as defined) and by any other present or future subsidiary of the borrower or of any companyny
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 11/11/1998Registro de uma garantia (395)
    • 20/10/2014Satisfação de uma garantia (MR04)

    OPUS HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    25/09/2018Início da liquidação
    17/12/2019Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profissional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0