INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaINTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03657126
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    JBS COMPUTER SERVICES LIMITED05/02/199905/02/1999
    GW 1000 LIMITED27/10/199827/10/1998

    Quais são as últimas contas de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até28/02/2013

    Qual é o status da última declaração anual para INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginas4.71

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 27/10/2013 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital05/11/2013

    Estado do capital em 05/11/2013

    • Capital: GBP 900,156.74
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/02/2013

    6 páginasAA

    Nomeação de Ms Vinodka Murria como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Denise Williams como secretário

    3 páginasAP03

    Endereço do domicílio registado alterado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* em 25/03/2013

    2 páginasAD01

    Término da nomeação de Kerry Crompton como diretor

    2 páginasTM01

    Nomeação de Barbara Ann Firth como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Mr Paul David Gibson como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Richard Preedy como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Neal Roberts como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Neal Roberts como secretário

    2 páginasTM02

    Exercício contabilístico anterior encurtado de 30/04/2013 para 28/02/2013

    3 páginasAA01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2012

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 27/10/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Richard Ian Preedy em 16/08/2012

    3 páginasCH01

    Nomeação de Richard Ian Preedy como diretor

    2 páginasAP01

    Detalhes do secretário alterados para Mr Neal Anthony Roberts em 16/05/2012

    2 páginasCH03

    Detalhes do diretor alterados para Mr Neal Anthony Roberts em 16/05/2012

    2 páginasCH01

    Detalhes do diretor alterados para Ms Kerry Jane Crompton em 16/05/2012

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* em 14/05/2012

    1 páginasAD01

    Quem são os diretores de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176951330001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    DEAKIN, David Raymond
    11 Witherford Way
    Selly Oak
    B29 4AY Birmingham
    Secretário
    11 Witherford Way
    Selly Oak
    B29 4AY Birmingham
    British77919810002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secretário
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secretário
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    BARNETT, Gary Michael
    27 Gloucester Road
    WS5 3PL Walsall
    West Midlands
    Diretor
    27 Gloucester Road
    WS5 3PL Walsall
    West Midlands
    British27665970001
    BLASDALE, Brian John
    Springbrook House
    Spring Lane, Lapworth
    B94 5NS Solihull
    Diretor
    Springbrook House
    Spring Lane, Lapworth
    B94 5NS Solihull
    British25611010002
    BOAG, Colin Mckinnon
    26 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    Diretor
    26 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish40646640001
    BRAZIER, Barry Allen
    30 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    30 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British62375560002
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Diretor
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    DEMPSEY, Simon Joseph
    Main Road
    Wigginton
    B79 9DS Tamworth
    The Old Vicarage
    Staffs
    Diretor
    Main Road
    Wigginton
    B79 9DS Tamworth
    The Old Vicarage
    Staffs
    EnglandUnited Kingdom113103110003
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Diretor
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    JONES, Malcolm David
    8 Hillwood Common Road
    B75 5QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Diretor
    8 Hillwood Common Road
    B75 5QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British73250170002
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Diretor
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Diretor
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    ST JOHN, Neil
    4 Broom Close
    Wath Upon Dearne
    S63 7JU Rotherham
    South Yorkshire
    Diretor
    4 Broom Close
    Wath Upon Dearne
    S63 7JU Rotherham
    South Yorkshire
    British71857040001
    VELUSSI, Luca
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomItalian113413330003
    WELLS, Colin Kenelm
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    Diretor
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    United KingdomBritish115361810001
    GW INCORPORATIONS LIMITED
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    68279000001

    INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 02/10/2007
    Entregue em 15/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transações
    • 15/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 25/01/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Deed of variation
    Criado em 05/12/2000
    Entregue em 07/12/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    The terms of fixed and floating charge dated 27TH january 1999 were amended so that the definition of "loan notes" now reads "the £500,000 units of secured loan notes 2003 of £1 each issued by the company in favour of the lender". The parties confirmed that the loan notes,as re-defined, will fall within the definition of "principal sum" (being part of the amount secured) in the fixed and floating charge dated 27 january 1999
    Breve descrição
    As set out in the fixed and floating charge dated 27TH january 1999.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transações
    • 07/12/2000Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge
    Criado em 22/03/1999
    Entregue em 26/03/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 19 march 1999
    Breve descrição
    A floating charge, all book debts full benefit of the rights and remedies charged assets.
    Pessoas com direito
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transações
    • 26/03/1999Registro de uma garantia (395)
    • 20/02/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Criado em 27/01/1999
    Entregue em 12/02/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as gw 1000 limited to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Breve descrição
    L/H 5TH floor kingston house 438 high street west bromwich west midlands B70 9LD. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transações
    • 12/02/1999Registro de uma garantia (395)
    • 30/04/2004Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture deed
    Criado em 27/01/1999
    Entregue em 11/02/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company (formerly known as gw 1000 limited) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Bank PLC
    Transações
    • 11/02/1999Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    31/01/2014Início da liquidação
    05/11/2014Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profissional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0