COMPUTER SOFTWARE LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | COMPUTER SOFTWARE LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03665527 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?
- Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica COMPUTER SOFTWARE LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| GUILDFORD MIDCO 2 LIMITED | 12/05/2010 | 12/05/2010 |
| COMPUTER SOFTWARE LIMITED | 12/07/1999 | 12/07/1999 |
| COMPUTER SOFTWARE HOLDINGS LIMITED | 26/03/1999 | 26/03/1999 |
| MAILCLEAR LIMITED | 11/11/1998 | 11/11/1998 |
Quais são as últimas contas de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 28/02/2013 |
Qual é o status da última declaração anual para COMPUTER SOFTWARE LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para COMPUTER SOFTWARE LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | GAZ2 | |||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 6 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaração de solvência | 4 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 11/11/2013 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/02/2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Renúncia do auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
Nomeação de Denise Williams como secretário | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Nomeação de Ms Vinodka Murria como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Kerry Crompton como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* em 25/03/2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Término da nomeação de Richard Preedy como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Barbara Ann Firth como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Paul David Gibson como diretor | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Neal Roberts como diretor | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Neal Roberts como secretário | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior encurtado de 30/04/2013 para 28/02/2013 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 11/11/2012 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Richard Ian Preedy em 16/08/2012 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Nomeação de Richard Ian Preedy como diretor | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* em 14/05/2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Memorando e estatutos | 26 páginas | MEM/ARTS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Quem são os diretores de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Denise | Secretário | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176951890001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Diretor | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Diretor | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Diretor | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| CHALLINGER, Sara | Secretário | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| EDGELL, Malcolm John | Secretário | 52 Moriconium Quay Lake Avenue BH15 4QP Poole Dorset | British | 33977500002 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Secretário | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| HARDIE, Alistair Peter | Secretário | Waveney Cottage Hill Grove, Lurgashall GU28 9EW Petworth West Sussex | British | 68788350001 | ||||||
| MAYTUM, Barry | Secretário | 4 Saint Marks Road RG9 1LJ Henley On Thames Oxfordshire | British | 69845130001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Secretário | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BAGGS, Michael Vincent | Diretor | 23 Brodrick Road SW7 7DX London | United Kingdom | British | 25974780001 | |||||
| BARNES, Kenneth Roy | Diretor | 29 St James Square BA1 2TT Bath Avon | British | 33463930001 | ||||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Diretor | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| CROSS, Neil Edward | Diretor | Ithaca Lower Park Road EX33 2LQ Braunton Devon | England | British | 26042290002 | |||||
| EDGELL, Malcolm John | Diretor | 52 Moriconium Quay Lake Avenue BH15 4QP Poole Dorset | British | 33977500002 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Diretor | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| HARDIE, Alistair Peter | Diretor | Waveney Cottage Hill Grove, Lurgashall GU28 9EW Petworth West Sussex | England | British | 68788350001 | |||||
| HOLLAND, Christopher | Diretor | Heathermount House Heathermount Drive RG45 6HL Crouthorne Berkshire | British | 77338810001 | ||||||
| JACKSON, Glenn Thomas | Diretor | Moss House SY14 7JJ Malpas Cheshire | England | British | 38721150004 | |||||
| JACKSON, Michael Edward Wilson | Diretor | 2 Castello Avenue Putney SW15 6EA London | United Kingdom | British | 40521530001 | |||||
| LEUW, Martin Philip | Diretor | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| LOWE, David Andrew | Diretor | Boreley House Boreley WR9 0HU Ombersley Worcestershire | British | 10441050001 | ||||||
| MAYTUM, Barry | Diretor | 4 Saint Marks Road RG9 1LJ Henley On Thames Oxfordshire | Uk | British | 69845130001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Diretor | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| PILECKA, Jolanta | Diretor | 15 Mallard Place TW1 4SW Twickenham Middlesex | United Kingdom | Polish | 90593990001 | |||||
| PINNING, Stephen Peter | Diretor | 79a Shepherds Hill Highgate N6 5RG London | British | 14848160001 | ||||||
| PREEDY, Richard Ian | Diretor | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Diretor | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 12470210004 | |||||
| TAYLOR, David John | Diretor | 16 Wheeler Avenue Penn HP10 8EN High Wycombe Buckinghamshire | England | British | 91573380001 | |||||
| VELUSSI, Luca | Diretor | 123 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QP London | United Kingdom | Italian | 113413330002 | |||||
| WELLS, Colin Kenelm | Diretor | Applecross House WV15 6NB Alveley Salop | United Kingdom | British | 115361810001 | |||||
| CLARKS NOMINEES LIMITED | Diretor | Great Western House Station Road RG1 1JX Reading Berkshire | 38350670001 | |||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
COMPUTER SOFTWARE LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Criado em 02/10/2007 Entregue em 15/10/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 27/07/2004 Entregue em 07/08/2004 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 07/10/2002 Entregue em 16/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the borrower to the security trsutee and/or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 06/12/2001 Entregue em 12/12/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge over credit balances | Criado em 10/05/2000 Entregue em 12/05/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The sum of £45,000 held on an account with the bank together with interest thereon. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Mortgage debenture | Criado em 16/12/1998 Entregue em 23/12/1998 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
COMPUTER SOFTWARE LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0