COMPUTER SOFTWARE LIMITED

COMPUTER SOFTWARE LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCOMPUTER SOFTWARE LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03665527
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    • Empresa não comercial (74990) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    GUILDFORD MIDCO 2 LIMITED12/05/201012/05/2010
    COMPUTER SOFTWARE LIMITED12/07/199912/07/1999
    COMPUTER SOFTWARE HOLDINGS LIMITED26/03/199926/03/1999
    MAILCLEAR LIMITED11/11/199811/11/1998

    Quais são as últimas contas de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até28/02/2013

    Qual é o status da última declaração anual para COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    GAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    6 páginas4.71

    Declaração de solvência

    4 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 11/11/2013 com lista completa de acionistas

    6 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital12/11/2013

    Estado do capital em 12/11/2013

    • Capital: GBP 464,523.75
    SH01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 28/02/2013

    7 páginasAA

    Renúncia do auditor

    2 páginasAUD

    Nomeação de Denise Williams como secretário

    3 páginasAP03

    Nomeação de Ms Vinodka Murria como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Kerry Crompton como diretor

    2 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* em 25/03/2013

    2 páginasAD01

    Término da nomeação de Richard Preedy como diretor

    2 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Barbara Ann Firth como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Mr Paul David Gibson como diretor

    3 páginasAP01

    Término da nomeação de Neal Roberts como diretor

    2 páginasTM01

    Término da nomeação de Neal Roberts como secretário

    2 páginasTM02

    Exercício contabilístico anterior encurtado de 30/04/2013 para 28/02/2013

    3 páginasAA01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/04/2012

    7 páginasAA

    Declaração anual preparada até 11/11/2012 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01

    Detalhes do diretor alterados para Richard Ian Preedy em 16/08/2012

    3 páginasCH01

    Nomeação de Richard Ian Preedy como diretor

    2 páginasAP01

    Endereço do domicílio registado alterado de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* em 14/05/2012

    1 páginasAD01

    Memorando e estatutos

    26 páginasMEM/ARTS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Quem são os diretores de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretário
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176951890001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Diretor
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secretário
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Secretário
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secretário
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Secretário
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    British68788350001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretário
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British69845130001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secretário
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAGGS, Michael Vincent
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    Diretor
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    United KingdomBritish25974780001
    BARNES, Kenneth Roy
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    Diretor
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    British33463930001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    Diretor
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United KingdomBritish158261930001
    CROSS, Neil Edward
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    Diretor
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    EnglandBritish26042290002
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Diretor
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Diretor
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Diretor
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish68788350001
    HOLLAND, Christopher
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    Diretor
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    British77338810001
    JACKSON, Glenn Thomas
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    Diretor
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    EnglandBritish38721150004
    JACKSON, Michael Edward Wilson
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    Diretor
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    United KingdomBritish40521530001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    LOWE, David Andrew
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    Diretor
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    British10441050001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Diretor
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    UkBritish69845130001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Diretor
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PINNING, Stephen Peter
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    Diretor
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    British14848160001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Diretor
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Diretor
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    TAYLOR, David John
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Diretor
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish91573380001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Diretor
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330002
    WELLS, Colin Kenelm
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    Diretor
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    United KingdomBritish115361810001
    CLARKS NOMINEES LIMITED
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    Diretor
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    38350670001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    COMPUTER SOFTWARE LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 02/10/2007
    Entregue em 15/10/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Citibank N.A.,London as Security Trustee
    Transações
    • 15/10/2007Registro de uma garantia (395)
    • 25/01/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Criado em 27/07/2004
    Entregue em 07/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 07/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 07/10/2002
    Entregue em 16/10/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the borrower to the security trsutee and/or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Elderstreet Capital Partners Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transações
    • 16/10/2002Registro de uma garantia (395)
    • 09/08/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 06/12/2001
    Entregue em 12/12/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 12/12/2001Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Charge over credit balances
    Criado em 10/05/2000
    Entregue em 12/05/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The sum of £45,000 held on an account with the bank together with interest thereon.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 12/05/2000Registro de uma garantia (395)
    • 04/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 16/12/1998
    Entregue em 23/12/1998
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 23/12/1998Registro de uma garantia (395)
    • 04/07/2001Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    COMPUTER SOFTWARE LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    31/01/2014Início da liquidação
    05/11/2014Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profissional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0