CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaCBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03712018
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    • (6603) /

    Onde fica CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Yorkshire House
    18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Merseyside
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CBS INSURANCE HOLDINGS PLC24/03/199924/03/1999
    FORECASTWIN PUBLIC LIMITED COMPANY11/02/199911/02/1999

    Quais são as últimas contas de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    7 páginas4.71

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 15/02/2012

    LRESSP

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 15/02/2012

    LRESSP

    Endereço do domicílio registado alterado de Unit C25 Jacks Place 6 Corbet Place London E1 6NN em 21/02/2012

    2 páginasAD01

    Contas consolidadas preparadas até 31/12/2010

    32 páginasAA

    Declaração anual preparada até 01/02/2011 com lista completa de acionistas

    18 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital03/03/2011

    Estado do capital em 03/03/2011

    • Capital: GBP 4,593.86
    SH01

    Contas consolidadas preparadas até 31/12/2009

    36 páginasAA

    Estado do capital em 18/08/2010

    • Capital: GBP 4,559.3855
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de alteração dos estatutos

    RES01
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluções

    Reduce share prem 14/07/2010
    RES13

    Declaração anual preparada até 02/02/2010. A lista de acionistas foi alterada

    22 páginasAR01

    Declaração anual preparada até 01/02/2010 com lista completa de acionistas

    22 páginasAR01

    Contas consolidadas preparadas até 31/12/2008

    35 páginasAA

    legacy

    13 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-MDSC

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Reduction of share premium account 17/12/2008
    RES13

    Certificado de re-registo de sociedade anónima para sociedade limitada

    1 páginasCERT10

    Re-registo do memorando e estatutos

    48 páginasMAR

    Quem são os diretores de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    FOX, Andrew Staley
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    Secretário
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    British43073160004
    EWART, David John
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    Diretor
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish23635320001
    HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    Diretor
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    United KingdomBritish56874210004
    CRAWFORD SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    Secretário
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    British97197960001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Secretário
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    MCMULLEN, Gerald Phipps
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    Secretário
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    British19668600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CASTELL, Andrew Sean
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    Diretor
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    British85990150001
    FABER, Robin Henry Grey
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    Diretor
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    EnglandBritish104985010001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Diretor
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    HOLBECH, Timothy Hugh
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    Diretor
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    British19390190001
    LEE, Michael Alan
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Diretor
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Australian92794500001
    MCCLEAN, Michael Hugh Patrick
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    Diretor
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    British57912890001
    ROYDS, Emma Louise
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    Diretor
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    British30320080003
    SPARROW, Andrew James
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    Diretor
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish19390170004
    WATSON, Michael John Bannatyne
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    Diretor
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    British64292610002
    WHITE, Graham John
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    Diretor
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish116735630001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Diretor nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Debenture
    Criado em 14/10/2004
    Entregue em 25/10/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transações
    • 25/10/2004Registro de uma garantia (395)
    Share charge
    Criado em 11/10/2004
    Entregue em 25/10/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the shares all dividends interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 25/10/2004Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 11/10/2004
    Entregue em 25/10/2004
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 25/10/2004Registro de uma garantia (395)
    • 13/11/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Floating charge
    Criado em 21/02/2002
    Entregue em 07/03/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Pessoas com direito
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871
    Transações
    • 07/03/2002Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 15/01/2002
    Entregue em 16/01/2002
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 16/01/2002Registro de uma garantia (395)
    • 13/11/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    Debenture
    Criado em 26/11/1999
    Entregue em 03/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Breve descrição
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 03/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 13/11/2004Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 18/10/2007Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    04/03/2013Data de dissolução
    15/02/2012Início da liquidação
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Paul J Fleming
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Profissional
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0