PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.

PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaPCSL SERVICES NO.1 LIMITED.
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03716148
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosNão
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.?

    Endereço do escritório registrado
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CCSL SERVICES NO. 1 LIMITED25/10/199925/10/1999
    CS SCF SERVICES NO. 1 LIMITED15/09/199915/09/1999
    CABOT £2 LIMITED06/08/199906/08/1999
    CABOT SERVICES LIMITED01/07/199901/07/1999
    CABOT SQUARE CAPITAL GP LIMITED 15/02/199915/02/1999

    Quais são as últimas contas de PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2014

    Quais são as últimas submissões para PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    14 páginasLIQ13

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 05/07/2017

    14 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    10 páginasLIQ10

    Os registos foram transferidos para a localização de inspeção registada Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester M60 0AL

    2 páginasAD03

    O endereço de inspeção do registo foi alterado para Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester M60 0AL

    2 páginasAD02

    Endereço do domicílio registado alterado de Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL England para Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR em 27/07/2016

    2 páginasAD01

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 06/07/2016

    LRESSP

    Declaração anual preparada até 23/05/2016 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital25/05/2016

    Estado do capital em 25/05/2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Endereço do domicílio registado alterado de 1 Angel Square Manchester M60 0AG para Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL em 25/04/2016

    1 páginasAD01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2014

    6 páginasAA

    Nomeação de Mr Stephen Aitken como diretor em 20/08/2015

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr David Michael Miller como diretor em 20/08/2015

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Daniel Mundy como diretor em 20/08/2015

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Clare Louise Gosling como diretor em 20/08/2015

    1 páginasTM01

    Declaração anual preparada até 30/06/2015 com lista completa de acionistas

    5 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/07/2015

    Estado do capital em 08/07/2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Término da nomeação de Brona Rose Mckeown como secretário em 30/03/2015

    1 páginasTM02

    Nomeação de Mr David Clive Whitehead como secretário em 30/03/2015

    2 páginasAP03

    Nomeação de Brona Rose Mckeown como secretário em 19/12/2014

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Katy Jane Arnold como secretário em 19/12/2014

    1 páginasTM02

    Nomeação de Katy Jane Arnold como secretário em 22/10/2014

    2 páginasAP03

    Término da nomeação de Susan Moss como secretário em 21/10/2014

    1 páginasTM02

    Quem são os diretores de PCSL SERVICES NO.1 LIMITED.?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WHITEHEAD, David Clive
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Secretário
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    196735830001
    AITKEN, Stephen
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Diretor
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish,Australian188712540001
    MCGIRR, Grahame George Scott
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Diretor
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandScottish184111130001
    MILLER, David Michael
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    United Kingdom
    Diretor
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    United Kingdom
    EnglandBritish201054530001
    MUNDY, Daniel
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Diretor
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish189420920001
    ARCKLESS, Jane Alison
    36 Pondfield Crescent
    AL4 9PF St. Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    36 Pondfield Crescent
    AL4 9PF St. Albans
    Hertfordshire
    British67947660001
    ARNOLD, Katy Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secretário
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    192243370001
    COUPE, Simon
    40 St Gabriels Manor
    25 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Secretário
    40 St Gabriels Manor
    25 Cormont Road
    SE5 9RA London
    British53532140001
    GREEN, Robin Sinclair
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    Secretário
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    British5782770001
    HUDSON, Matthew Donald Jeremy
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    Secretário
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    British72420070002
    HYLTON, Rosemarie
    Silverdene
    Shirley Church Road
    CR0 5AF Shirley
    Surrey
    Secretário
    Silverdene
    Shirley Church Road
    CR0 5AF Shirley
    Surrey
    British115762060001
    MCKEOWN, Brona Rose
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Secretário
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    193732930001
    MILLS, Paul Andrew
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    Secretário
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    British34173070002
    MOSS, Susan
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Secretário
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    153017610001
    OWEN, Robert James Holland
    Waterside Close
    DE22 1JT Derby
    7
    Derbyshire
    Secretário
    Waterside Close
    DE22 1JT Derby
    7
    Derbyshire
    British73708980005
    WADE, Patricia Anne
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secretário
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    147966240001
    BANNIER, Paul Roy
    Ashleigh
    Rue De La Cache, St. Pierre Du Bois
    GY7 9HQ Guernsey
    Channel Islands
    Diretor
    Ashleigh
    Rue De La Cache, St. Pierre Du Bois
    GY7 9HQ Guernsey
    Channel Islands
    British65883180001
    CLARK, James Roy
    21 Ladbroke Square
    W11 3NA London
    Diretor
    21 Ladbroke Square
    W11 3NA London
    United KingdomAmerican65072010002
    GOSLING, Clare Louise
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Diretor
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish204863170001
    GREEN, Peter
    21 Main Street
    YO10 5EA Heslington
    York
    Diretor
    21 Main Street
    YO10 5EA Heslington
    York
    British74913270001
    GREEN, Robin Sinclair
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    Diretor
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    British5782770001
    GREGORY, Gerald Arthur
    Gatepiece House
    Quarry Bank
    DE4 3LF Matlock
    Derbyshire
    Diretor
    Gatepiece House
    Quarry Bank
    DE4 3LF Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritish31843730001
    HUDSON, Matthew Donald Jeremy
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    Diretor
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    British72420070002
    HUGHES, John Richard
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Diretor
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    EnglandBritish146426540002
    KATOVSKY, Jon Ian
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Diretor
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    United KingdomAmerican147983920001
    LEE, Phillip Andrew
    11 Badger Road
    SK10 4JG Prestbury
    Cheshire
    Diretor
    11 Badger Road
    SK10 4JG Prestbury
    Cheshire
    United KingdomBritish89215420001
    MCCARTHY, David James
    Far End
    Sheepscombe
    GL6 7RL Stroud
    Knapp House
    Gloucestershire
    Diretor
    Far End
    Sheepscombe
    GL6 7RL Stroud
    Knapp House
    Gloucestershire
    EnglandBritish91557750002
    MILLS, Paul Andrew
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    Diretor
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritish34173070002
    MITCHISON, David Robert
    Winchester House
    Grand Douit Road, St. Sampson
    GY2 4WG Guernsey
    Channel Islands
    Diretor
    Winchester House
    Grand Douit Road, St. Sampson
    GY2 4WG Guernsey
    Channel Islands
    British65883240001
    RICHARDSON, Neville Brian
    Doone Cottage 37 Hough Lane
    SK9 2LH Wilmslow
    Cheshire
    Diretor
    Doone Cottage 37 Hough Lane
    SK9 2LH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish73311810001
    ROWAN, John Laidlaw
    c/o C/O Governance Department
    Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th
    United Kingdom
    Diretor
    c/o C/O Governance Department
    Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th
    United Kingdom
    ScotlandBritish146402370001
    RUSSELL, Andrew Nicholas
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish91395820001
    SOULSBY, Philip Dominic
    The Ferrers
    Milton Gardens St Martins
    GY4 6NU Guernsey
    Diretor
    The Ferrers
    Milton Gardens St Martins
    GY4 6NU Guernsey
    United KingdomBritish126119030001
    TWEEDY, David
    c/o C/O Governance Department
    Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th
    United Kingdom
    Diretor
    c/o C/O Governance Department
    Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    5th
    United Kingdom
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British109457050001
    TWEEDY, David
    Afton
    Onslow Crescent
    GU22 7AT Woking
    Surrey
    Diretor
    Afton
    Onslow Crescent
    GU22 7AT Woking
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British109457050001

    PCSL SERVICES NO.1 LIMITED. possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    06/07/2016Início da liquidação
    06/12/2017Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profissional
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profissional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0