UL REALISATIONS 2013 LIMITED

UL REALISATIONS 2013 LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaUL REALISATIONS 2013 LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03742287
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?

    • Atividades de médicos especialistas (86220) / Atividades de saúde humana e ação social

    Onde fica UL REALISATIONS 2013 LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    ULTRALASE LIMITED16/03/200016/03/2000
    NUSIGHT LIMITED17/11/199917/11/1999
    BUSINESSINSTANT LIMITED29/03/199929/03/1999

    Quais são as últimas contas de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2010

    Quais são as últimas submissões para UL REALISATIONS 2013 LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores

    20 páginasLIQ14

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2021

    16 páginasLIQ03

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2020

    17 páginasLIQ03

    Aviso da conclusão do acordo voluntário

    17 páginasCVA4

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2019

    16 páginasLIQ03

    Nomeação de um liquidador voluntário

    3 páginas600

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2018

    16 páginasCVA3

    Remoção do liquidatário por ordem judicial

    11 páginasLIQ10

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2018

    15 páginasLIQ03

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2017

    16 páginasCVA3

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2017

    16 páginasLIQ03

    Endereço do domicílio registado alterado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL para Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU em 08/09/2017

    1 páginasAD01

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2016

    9 páginas1.3

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2016

    13 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de C/O Resolve Partners Limited One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB England para 48 Warwick Street London W1B 5NL em 31/08/2016

    2 páginasAD01

    Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor

    páginas1.1

    Despacho judicial de insolvência

    Court order INSOLVENCY:Removal and replacement of supervisor.
    12 páginasLIQ MISC OC

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2015

    10 páginas1.3

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2015

    15 páginas4.68

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2015

    15 páginas4.68

    Endereço do domicílio registado alterado de Resolve Partners Llp One America Square Crosswall London EC3N 2LB para C/O Resolve Partners Limited One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB em 03/11/2015

    1 páginasAD01

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    3 páginasF10.2

    Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2014

    10 páginas1.3

    Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia

    3 páginasF10.2

    Quem são os diretores de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    RABONE, John Harry William
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    Secretário
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    174211290001
    AMBROSE, Russell Keith
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    Diretor
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    United KingdomBritishProprietor16529210006
    RABONE, John Harry William
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    Diretor
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    EnglandBritishFinancial Director23461290003
    ALCOCK, Julie Ann
    7 Sunningdale Drive
    LS17 7SH Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    7 Sunningdale Drive
    LS17 7SH Leeds
    West Yorkshire
    British68491690001
    CHISHOLM, Iain Macdonald
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    Secretário
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    BritishInterim Fd231355750001
    CLARKSON, James Norman
    12 Honey Head Lane
    Honley
    HD9 6RW Holmfirth
    West Yorkshire
    Secretário
    12 Honey Head Lane
    Honley
    HD9 6RW Holmfirth
    West Yorkshire
    BritishFinance Director108928820001
    JACKSON, Debbie
    Kings Court 12 King Street
    LS1 2HL Leeds
    West Yorkshire
    Secretário
    Kings Court 12 King Street
    LS1 2HL Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor69812230001
    LOY, Timothy John
    Kirkstones
    Mill Lane, Cloughton
    YO13 0AB Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    Kirkstones
    Mill Lane, Cloughton
    YO13 0AB Scarborough
    North Yorkshire
    BritishFinance Director63495490002
    NEAVE, Christopher Gage
    Fullicar House
    Fullicar Lane, Brompton
    DL6 2RW Northallerton
    North Yorkshire
    Secretário
    Fullicar House
    Fullicar Lane, Brompton
    DL6 2RW Northallerton
    North Yorkshire
    British37809870002
    NEVINS, Rachael Rebecca
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    Secretário
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    150743170001
    SIMPSON, Jonathan Paul
    10 Kepstorn Road
    LS16 5HL Leeds
    Secretário
    10 Kepstorn Road
    LS16 5HL Leeds
    BritishFinance Director119659590002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretário nomeado
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BOND, Keith
    Hartfield
    Sheardale Honley
    HD9 6RU Holmfirth
    West Yorkshire
    Diretor
    Hartfield
    Sheardale Honley
    HD9 6RU Holmfirth
    West Yorkshire
    BritishMarketing Director123528140001
    CLARKSON, James Norman
    12 Honey Head Lane
    Honley
    HD9 6RW Holmfirth
    West Yorkshire
    Diretor
    12 Honey Head Lane
    Honley
    HD9 6RW Holmfirth
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director108928820001
    CONNER, Diane May
    Flat 39 The Quays
    3 Concordia Street
    LS1 4ES Leeds
    Yorkshire
    Diretor
    Flat 39 The Quays
    3 Concordia Street
    LS1 4ES Leeds
    Yorkshire
    BritishOperations Director79719990001
    DUNWALD, Christoph
    L/Santa Rosa 9
    Pta 14
    FOREIGN Valencia
    46201
    Spain
    Diretor
    L/Santa Rosa 9
    Pta 14
    FOREIGN Valencia
    46201
    Spain
    GermanBusiness Manager119660000001
    FERGUSON, Andrew
    2 Fitzwalter Road
    CM6 3FH Little Dunmow
    Essex
    Diretor
    2 Fitzwalter Road
    CM6 3FH Little Dunmow
    Essex
    United KingdomBritishAccountant174600320001
    GARCIA, Fernando
    Calle Lira Castellonense
    No.4 Pl-A Castello De La Ribera
    FOREIGN Valencia
    Spain
    Diretor
    Calle Lira Castellonense
    No.4 Pl-A Castello De La Ribera
    FOREIGN Valencia
    Spain
    SpanishDirector107478940001
    GONZALEZ, Rafael
    Panama 9
    Soto Del Real
    Mardid
    28791
    Spain
    Diretor
    Panama 9
    Soto Del Real
    Mardid
    28791
    Spain
    SpanishDirector112766190001
    HUGHES, Jonathon Charles
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    Diretor
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    United KingdomBritishCommercial Director137252380001
    IRELAND, Janice Mary
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    Diretor
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    EnglandBritishCompany Director174204440001
    KOROLKIEWICZ, Mark Nicholas
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    Diretor
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    EnglandBritishClinical Services Director137325730001
    LOY, Timothy John
    Kirkstones
    Mill Lane, Cloughton
    YO13 0AB Scarborough
    North Yorkshire
    Diretor
    Kirkstones
    Mill Lane, Cloughton
    YO13 0AB Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director63495490002
    MASON, Roderick David
    22 John Gilmour Way
    Burley
    LS29 7SR Ilkley
    West Yorkshire
    Diretor
    22 John Gilmour Way
    Burley
    LS29 7SR Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishSales Director146872950001
    MCMANUS, Beata
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    Diretor
    Bristol Road
    B5 7XJ Birmingham
    96
    England
    EnglandBritishCompany Director158014170001
    MERLADET, Jorge
    Pza. Reyes Magos 11, 12'A,
    FOREIGN 28007 Madrid
    Spain
    Diretor
    Pza. Reyes Magos 11, 12'A,
    FOREIGN 28007 Madrid
    Spain
    SpanishDirector105673620001
    MICO OLCINA, Jose Vicente
    C/ Joaquin Costa 44 2a 4o
    Valencia
    46005
    Spain
    Diretor
    C/ Joaquin Costa 44 2a 4o
    Valencia
    46005
    Spain
    SpanishDirector119659670001
    NEAVE, Christopher Gage
    Fullicar House
    Fullicar Lane, Brompton
    DL6 2RW Northallerton
    North Yorkshire
    Diretor
    Fullicar House
    Fullicar Lane, Brompton
    DL6 2RW Northallerton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector37809870002
    NEVINS, Rachael Rebecca
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    Diretor
    3 The Embankment
    Sovereign Street
    LS1 4BJ Leeds
    EnglandBritishFinance Director113010610001
    PALILLO, Lisa
    14a Royal Crescent
    HG2 8AB Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    14a Royal Crescent
    HG2 8AB Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishMarketing Director79719860001
    PLANA ANDRES, Francisco Javier
    Calle Pizarro 13
    FOREIGN Valencia
    46004
    Spain
    Diretor
    Calle Pizarro 13
    FOREIGN Valencia
    46004
    Spain
    SpanishDirector113498860001
    RIVERA, Francisco
    Calle Lira Castellonense
    No.4 Pl-A Castello De La Ribera
    FOREIGN Valencia
    Spain
    Diretor
    Calle Lira Castellonense
    No.4 Pl-A Castello De La Ribera
    FOREIGN Valencia
    Spain
    SpanishDirector107479090001
    SIMPSON, Jonathan Paul
    10 Kepstorn Road
    LS16 5HL Leeds
    Diretor
    10 Kepstorn Road
    LS16 5HL Leeds
    EnglandBritishFinance Director119659590002
    STREET, Geoffrey Graham
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Diretor
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector70418720001
    THIRKILL, Andrew Robin
    20 Sovereign Park
    HG1 2SJ Harrogate
    West Yorkshire
    Diretor
    20 Sovereign Park
    HG1 2SJ Harrogate
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector79667970001

    UL REALISATIONS 2013 LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 22/05/2013
    Entregue em 31/05/2013
    Pendente
    Breve descrição
    Notification of addition to or amendment of charge.
    A garantia flutuante cobre tudo: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC
    Transações
    • 31/05/2013Registro de uma garantia (MR01)
    Debenture
    Criado em 17/03/2008
    Entregue em 20/03/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for and on Behalf of the Secured Parties
    Transações
    • 20/03/2008Registro de uma garantia (395)
    • 05/03/2013Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    Rent deposit deed
    Criado em 21/12/2007
    Entregue em 04/01/2008
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    The initial rent deposit of £18,912.32.
    Pessoas com direito
    • Bae Systems Pension Fund Trustees Limited
    Transações
    • 04/01/2008Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 16/07/2003
    Entregue em 21/07/2003
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Granville Baird Capital Partners Limited
    Transações
    • 21/07/2003Registro de uma garantia (395)
    • 03/06/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Rent deposit deed
    Criado em 05/05/2000
    Entregue em 22/05/2000
    Pendente
    Montante garantido
    £25,562 due from the company to the chargee
    Breve descrição
    Monies in respect of rent for a lease of 14 highfield road edgbaston birmingham.
    Pessoas com direito
    • William Henry George Wilks
    • Sir Michael William Bunbury
    • Sir Charles Christian Nicholson
    Transações
    • 22/05/2000Registro de uma garantia (395)
    Charge
    Criado em 02/12/1999
    Entregue em 21/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The company with full title guarantee charges the shares and the derivative assets to the trustee the shares are the ordinary shares of 5 pence each in the capital of the corneal laser centre PLC now or in the future owned by or on behalf of the company. All stocks shares warrants or other securities rights.
    Pessoas com direito
    • Granville Private Equity Managers Limited
    Transações
    • 21/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 12/04/2000Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 03/06/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Memorandum of deposit of stocks and shares
    Criado em 02/12/1999
    Entregue em 15/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All stocks shares bonds receipts or other property and/or the proceeds of sale thereof and documents evidencing the companys title thereto now or after deposited with the bank or transferred to the bank or its nominees by the companyas continuing security all costs expenses and interest * see form 395 for further details *.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 15/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 12/04/2000Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 19/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Legal mortgage of life policy of c g neave
    Criado em 02/12/1999
    Entregue em 15/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Plan document from guardian financial services providing life insurance with critical illness and total and permanent disability protection benefit of £1,000,000 from 29 november 1999 for a term of 5 years policy number L0195158811.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 15/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 19/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage debenture
    Criado em 02/12/1999
    Entregue em 15/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 15/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 19/08/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 02/12/1999
    Entregue em 15/12/1999
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies or liabilities due owing or incurred by the company to the stockholders in accordance with or pursuant to the loan stock instrument or otherwise in any manner whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Granville Private Equity Managers Limited ("the Trustee")
    Transações
    • 15/12/1999Registro de uma garantia (395)
    • 03/06/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    UL REALISATIONS 2013 LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    21/12/2012Data da reunião para aprovar o CVA
    19/12/2019Data de finalização ou terminação do CVA
    Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA)
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    David Harry Gilbert
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profissional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Douglas Ernle Money
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profissional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DataTipo
    30/10/2013Início da administração
    16/10/2014Fim da administração
    Em administração
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Simon Harris
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Profissional
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Mark Supperstone
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    Profissional
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    3
    DataTipo
    16/10/2014Início da liquidação
    19/10/2022Data de dissolução
    Liquidação voluntária de credores
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Profissional
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Harris
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Liquidatário proposto
    One America Square Crosswall
    EC3N 2LB London
    Mark Supperstone
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London
    Liquidatário proposto
    One America Square
    Crosswall
    EC3N 2LB London

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0