UL REALISATIONS 2013 LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | UL REALISATIONS 2013 LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 03742287 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Sim |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?
- Atividades de médicos especialistas (86220) / Atividades de saúde humana e ação social
Onde fica UL REALISATIONS 2013 LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
ULTRALASE LIMITED | 16/03/2000 | 16/03/2000 |
NUSIGHT LIMITED | 17/11/1999 | 17/11/1999 |
BUSINESSINSTANT LIMITED | 29/03/1999 | 29/03/1999 |
Quais são as últimas contas de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2010 |
Quais são as últimas submissões para UL REALISATIONS 2013 LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores | 20 páginas | LIQ14 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2021 | 16 p áginas | LIQ03 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2020 | 17 páginas | LIQ03 | ||
Aviso da conclusão do acordo voluntário | 17 páginas | CVA4 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2019 | 16 páginas | LIQ03 | ||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||
Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2018 | 16 páginas | CVA3 | ||
Remoção do liquidatário por ordem judicial | 11 páginas | LIQ10 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2018 | 15 páginas | LIQ03 | ||
Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2017 | 16 páginas | CVA3 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2017 | 16 páginas | LIQ03 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL para Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU em 08/09/2017 | 1 páginas | AD01 | ||
Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2016 | 9 páginas | 1.3 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2016 | 13 páginas | 4.68 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Resolve Partners Limited One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB England para 48 Warwick Street London W1B 5NL em 31/08/2016 | 2 páginas | AD01 | ||
Aviso ao Registo Comercial do acordo voluntário de empresas que entra em vigor | páginas | 1.1 | ||
Despacho judicial de insolvência Court order INSOLVENCY:Removal and replacement of supervisor. | 12 páginas | LIQ MISC OC | ||
Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2015 | 10 páginas | 1.3 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2015 | 15 páginas | 4.68 | ||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 15/10/2015 | 15 páginas | 4.68 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de Resolve Partners Llp One America Square Crosswall London EC3N 2LB para C/O Resolve Partners Limited One America Square 17 Crosswall London EC3N 2LB em 03/11/2015 | 1 páginas | AD01 | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 3 páginas | F10.2 | ||
Extrato de receitas e despesas do supervisor do acordo voluntário até 20/12/2014 | 10 páginas | 1.3 | ||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 3 páginas | F10.2 | ||
Quem são os diretores de UL REALISATIONS 2013 LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABONE, John Harry William | Secretário | Bristol Road B5 7XJ Birmingham 96 England | 174211290001 | |||||||
AMBROSE, Russell Keith | Diretor | Bristol Road B5 7XJ Birmingham 96 England | United Kingdom | British | Proprietor | 16529210006 | ||||
RABONE, John Harry William | Diretor | Bristol Road B5 7XJ Birmingham 96 England | England | British | Financial Director | 23461290003 | ||||
ALCOCK, Julie Ann | Secretário | 7 Sunningdale Drive LS17 7SH Leeds West Yorkshire | British | 68491690001 | ||||||
CHISHOLM, Iain Macdonald | Secretário | 3 The Embankment Sovereign Street LS1 4BJ Leeds | British | Interim Fd | 231355750001 | |||||
CLARKSON, James Norman | Secretário | 12 Honey Head Lane Honley HD9 6RW Holmfirth West Yorkshire | British | Finance Director | 108928820001 | |||||
JACKSON, Debbie | Secretário | Kings Court 12 King Street LS1 2HL Leeds West Yorkshire | British | Solicitor | 69812230001 | |||||
LOY, Timothy John | Secretário | Kirkstones Mill Lane, Cloughton YO13 0AB Scarborough North Yorkshire | British | Finance Director | 63495490002 | |||||
NEAVE, Christopher Gage | Secretário | Fullicar House Fullicar Lane, Brompton DL6 2RW Northallerton North Yorkshire | British | 37809870002 | ||||||
NEVINS, Rachael Rebecca | Secretário | 3 The Embankment Sovereign Street LS1 4BJ Leeds | 150743170001 | |||||||
SIMPSON, Jonathan Paul | Secretário | 10 Kepstorn Road LS16 5HL Leeds | British | Finance Director | 119659590002 | |||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
BOND, Keith | Diretor | Hartfield Sheardale Honley HD9 6RU Holmfirth West Yorkshire | British | Marketing Director | 123528140001 | |||||
CLARKSON, James Norman | Diretor | 12 Honey Head Lane Honley HD9 6RW Holmfirth West Yorkshire | England | British | Finance Director | 108928820001 | ||||
CONNER, Diane May | Diretor | Flat 39 The Quays 3 Concordia Street LS1 4ES Leeds Yorkshire | British | Operations Director | 79719990001 | |||||
DUNWALD, Christoph | Diretor | L/Santa Rosa 9 Pta 14 FOREIGN Valencia 46201 Spain | German | Business Manager | 119660000001 | |||||
FERGUSON, Andrew | Diretor | 2 Fitzwalter Road CM6 3FH Little Dunmow Essex | United Kingdom | British | Accountant | 174600320001 | ||||
GARCIA, Fernando | Diretor | Calle Lira Castellonense No.4 Pl-A Castello De La Ribera FOREIGN Valencia Spain | Spanish | Director | 107478940001 | |||||
GONZALEZ, Rafael | Diretor | Panama 9 Soto Del Real Mardid 28791 Spain | Spanish | Director | 112766190001 | |||||
HUGHES, Jonathon Charles | Diretor | 3 The Embankment Sovereign Street LS1 4BJ Leeds | United Kingdom | British | Commercial Director | 137252380001 | ||||
IRELAND, Janice Mary | Diretor | Bristol Road B5 7XJ Birmingham 96 England | England | British | Company Director | 174204440001 | ||||
KOROLKIEWICZ, Mark Nicholas | Diretor | 3 The Embankment Sovereign Street LS1 4BJ Leeds | England | British | Clinical Services Director | 137325730001 | ||||
LOY, Timothy John | Diretor | Kirkstones Mill Lane, Cloughton YO13 0AB Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 63495490002 | ||||
MASON, Roderick David | Diretor | 22 John Gilmour Way Burley LS29 7SR Ilkley West Yorkshire | United Kingdom | British | Sales Director | 146872950001 | ||||
MCMANUS, Beata | Diretor | Bristol Road B5 7XJ Birmingham 96 England | England | British | Company Director | 158014170001 | ||||
MERLADET, Jorge | Diretor | Pza. Reyes Magos 11, 12'A, FOREIGN 28007 Madrid Spain | Spanish | Director | 105673620001 | |||||
MICO OLCINA, Jose Vicente | Diretor | C/ Joaquin Costa 44 2a 4o Valencia 46005 Spain | Spanish | Director | 119659670001 | |||||
NEAVE, Christopher Gage | Diretor | Fullicar House Fullicar Lane, Brompton DL6 2RW Northallerton North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 37809870002 | ||||
NEVINS, Rachael Rebecca | Diretor | 3 The Embankment Sovereign Street LS1 4BJ Leeds | England | British | Finance Director | 113010610001 | ||||
PALILLO, Lisa | Diretor | 14a Royal Crescent HG2 8AB Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Marketing Director | 79719860001 | ||||
PLANA ANDRES, Francisco Javier | Diretor | Calle Pizarro 13 FOREIGN Valencia 46004 Spain | Spanish | Director | 113498860001 | |||||
RIVERA, Francisco | Diretor | Calle Lira Castellonense No.4 Pl-A Castello De La Ribera FOREIGN Valencia Spain | Spanish | Director | 107479090001 | |||||
SIMPSON, Jonathan Paul | Diretor | 10 Kepstorn Road LS16 5HL Leeds | England | British | Finance Director | 119659590002 | ||||
STREET, Geoffrey Graham | Diretor | 9 Fulwith Mill Lane HG2 8HJ Harrogate North Yorkshire | England | British | Director | 70418720001 | ||||
THIRKILL, Andrew Robin | Diretor | 20 Sovereign Park HG1 2SJ Harrogate West Yorkshire | England | British | Director | 79667970001 |
UL REALISATIONS 2013 LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Criado em 22/05/2013 Entregue em 31/05/2013 | Pendente | ||
Breve descrição Notification of addition to or amendment of charge. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 17/03/2008 Entregue em 20/03/2008 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Rent deposit deed | Criado em 21/12/2007 Entregue em 04/01/2008 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição The initial rent deposit of £18,912.32. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 16/07/2003 Entregue em 21/07/2003 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Rent deposit deed | Criado em 05/05/2000 Entregue em 22/05/2000 | Pendente | Montante garantido £25,562 due from the company to the chargee | |
Breve descrição Monies in respect of rent for a lease of 14 highfield road edgbaston birmingham. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Charge | Criado em 02/12/1999 Entregue em 21/12/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The company with full title guarantee charges the shares and the derivative assets to the trustee the shares are the ordinary shares of 5 pence each in the capital of the corneal laser centre PLC now or in the future owned by or on behalf of the company. All stocks shares warrants or other securities rights. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Memorandum of deposit of stocks and shares | Criado em 02/12/1999 Entregue em 15/12/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição All stocks shares bonds receipts or other property and/or the proceeds of sale thereof and documents evidencing the companys title thereto now or after deposited with the bank or transferred to the bank or its nominees by the companyas continuing security all costs expenses and interest * see form 395 for further details *. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Legal mortgage of life policy of c g neave | Criado em 02/12/1999 Entregue em 15/12/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Plan document from guardian financial services providing life insurance with critical illness and total and permanent disability protection benefit of £1,000,000 from 29 november 1999 for a term of 5 years policy number L0195158811. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Mortgage debenture | Criado em 02/12/1999 Entregue em 15/12/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture | Criado em 02/12/1999 Entregue em 15/12/1999 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies or liabilities due owing or incurred by the company to the stockholders in accordance with or pursuant to the loan stock instrument or otherwise in any manner whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
UL REALISATIONS 2013 LIMITED possui casos de insolvência?
Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Acordo voluntário de reestruturação empresarial (CVA) |
| |||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Em administração |
| |||||||||||||||||||||||||||
3 |
| Liquidação voluntária de credores |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0