MESSAGELABS GROUP LIMITED

MESSAGELABS GROUP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaMESSAGELABS GROUP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03828739
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de MESSAGELABS GROUP LIMITED?

    • Outras atividades de serviços de tecnologia da informação (62090) / Informação e comunicação

    Onde fica MESSAGELABS GROUP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    England
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de MESSAGELABS GROUP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    STAR TECHNOLOGY GROUP LIMITED16/09/199916/09/1999
    FACTPART LIMITED20/08/199920/08/1999

    Quais são as últimas contas de MESSAGELABS GROUP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até03/04/2020

    Quais são as últimas submissões para MESSAGELABS GROUP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    resolution

    Resolução de capitalização ou de emissão de ações bónus

    The sum of gbp 9,176,314 be capitalised 28/01/2021
    RES14

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado do capital em 10/02/2021

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancelling the share premium account of the company 28/01/2021
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 28/01/2021

    • Capital: GBP 12,536,994.1
    3 páginasSH01

    Contas anuais preparadas até 03/04/2020

    22 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 20/08/2020 com atualizações

    4 páginasCS01

    Alteração dos detalhes de Symantec (Uk) Holding Limited como pessoa com controlo significativo em 01/10/2020

    2 páginasPSC05

    Endereço do domicílio registado alterado de 200 Brook Drive Green Park Reading Berkshire RG2 6UB para 100 New Bridge Street London EC4V 6JA em 01/10/2020

    1 páginasAD01

    Nomeação de Mrs Kara Shantell Jordan como diretor em 14/05/2020

    2 páginasAP01

    Nomeação de Mr Bryan Seuk Ko como diretor em 14/05/2020

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Norman Osumi como diretor em 14/05/2020

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Eunice Jeeyoon Kim como diretor em 14/05/2020

    1 páginasTM01

    Detalhes do diretor alterados para Eunice Jeeyoon Kim em 20/01/2020

    2 páginasCH01

    Endereço do domicílio registado alterado de Reading International Business Park Reading International Business Park Reading RG2 6DH United Kingdom para 200 Brook Drive Green Park Reading Berkshire RG2 6UB em 20/01/2020

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 29/03/2019

    20 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 20/08/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de 350 Brook Drive Green Park Reading Berkshire RG2 6UH para Reading International Business Park Reading International Business Park Reading RG2 6DH em 25/02/2019

    1 páginasAD01

    Contas anuais preparadas até 30/03/2018

    20 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 20/08/2018 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 01/06/2018

    • Capital: GBP 3,360,680.0
    5 páginasSH01

    Quem são os diretores de MESSAGELABS GROUP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    JORDAN, Kara Shantell
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    Diretor
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    United StatesBritishHr Manager269820410001
    KO, Bryan Seuk
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    Diretor
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    United StatesAmericanAttorney269820000001
    CHANDLER, Stephen Charles
    55 Palace Court, Moscow Road
    W2 4JB London
    Secretário
    55 Palace Court, Moscow Road
    W2 4JB London
    BritishFinance Director121840470001
    MACFARLANE, Michelle Marie
    3 Butts Cottage
    Poulton
    GL7 5HY Cirencester
    Gloucestershire
    Secretário
    3 Butts Cottage
    Poulton
    GL7 5HY Cirencester
    Gloucestershire
    BritishOperations Director51018950002
    MILBOURN, Ian Leathley
    Battle Lane
    Chew Magna
    BS40 8PX Bristol
    Little Gables
    Avon
    United Kingdom
    Secretário
    Battle Lane
    Chew Magna
    BS40 8PX Bristol
    Little Gables
    Avon
    United Kingdom
    BritishAccountant142782550001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretário nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ATKINS, Richard Charles
    Crescent House
    The Quillot, Burwood Park
    KT12 5BY Walton-On-Thames
    Surrey
    Diretor
    Crescent House
    The Quillot, Burwood Park
    KT12 5BY Walton-On-Thames
    Surrey
    EnglandBritishAccountant104670700001
    CHAMBERLAIN, Adrian
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    Diretor
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    BritishCeo117106730001
    CHANDLER, Stephen Charles
    55 Palace Court, Moscow Road
    W2 4JB London
    Diretor
    55 Palace Court, Moscow Road
    W2 4JB London
    EnglandBritishFinance Director121840470001
    COLE, Michael
    70 East Cedar Apartment 8w
    Chicago
    FOREIGN Illinois
    60611
    Usa
    Diretor
    70 East Cedar Apartment 8w
    Chicago
    FOREIGN Illinois
    60611
    Usa
    AmericanVenture Capital96675120001
    FLYNN, Aidan
    Symantec Ltd
    Ballycoolin Business Park
    Blanchardstown
    Co. Dublin
    Ireland
    Diretor
    Symantec Ltd
    Ballycoolin Business Park
    Blanchardstown
    Co. Dublin
    Ireland
    IrelandIrishAccountant180478970001
    HERZOG, Carolyn Beth
    1240 Lansdowne Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AB Gloucester
    Gloucestershire
    Diretor
    1240 Lansdowne Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AB Gloucester
    Gloucestershire
    UkUs CitizenAttorney133265970001
    KIM, Eunice Jeeyoon
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UB Reading
    200
    Berkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UB Reading
    200
    Berkshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanAttorney202840050001
    KIRBY, James
    527 Cherry Street
    Winnetka
    Illinois 60093
    Usa
    Diretor
    527 Cherry Street
    Winnetka
    Illinois 60093
    Usa
    UsaVenture Capital94538630001
    LAUBSCHER, Kristen Joy
    1240 Lansdowne Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AB Gloucester
    Gloucestershire
    Diretor
    1240 Lansdowne Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AB Gloucester
    Gloucestershire
    UsaUnited StatesBusiness Executive Finance122903560003
    LAUGHTON, Jonathan James
    Flat 1
    107 The Park
    GL50 2RW Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Flat 1
    107 The Park
    GL50 2RW Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishSales Director66363070001
    LEWIS, Duncan James Daragon
    Flat 9 12 Charles Street
    W1X 7HB London
    Diretor
    Flat 9 12 Charles Street
    W1X 7HB London
    United KingdomBritishDirector53132170003
    MACFARLANE, Michelle Marie
    3 Butts Cottage
    Poulton
    GL7 5HY Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    3 Butts Cottage
    Poulton
    GL7 5HY Cirencester
    Gloucestershire
    BritishOperations Director51018950002
    MCCABE, Austin Eugene
    21 The Old Golf Links
    Coast Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Diretor
    21 The Old Golf Links
    Coast Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishManaging Director162477300001
    MCKINLEY, John
    Rolling Meadow Drive
    Great Falls
    11624
    Va 22066
    Usa
    Diretor
    Rolling Meadow Drive
    Great Falls
    11624
    Va 22066
    Usa
    UsaDirector132297170001
    MCNALLY, Ryan
    201 West 17th Street Apt 9c
    New York
    10011
    Usa
    Diretor
    201 West 17th Street Apt 9c
    New York
    10011
    Usa
    AmericanVenture Capital73240920001
    MOGLIA, Nicholas Julian
    Markstone
    Browns Lane
    OX7 3QW Charlbury
    Oxfordshire
    Diretor
    Markstone
    Browns Lane
    OX7 3QW Charlbury
    Oxfordshire
    BritishFinance Director75788820001
    MORRISON, David John
    904 Drake House Dolphin Square
    SW1V 3NW London
    Diretor
    904 Drake House Dolphin Square
    SW1V 3NW London
    United KingdomBritishInvestment Manager29500910002
    OSUMI, Norman
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UB Reading
    200
    Berkshire
    Diretor
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UB Reading
    200
    Berkshire
    United StatesAmericanCertified Public Accountant162714780001
    RICH, Brian
    16 Applegreen Drive
    FOREIGN Old Westbury New York
    Nassau 11568
    Usa
    Diretor
    16 Applegreen Drive
    FOREIGN Old Westbury New York
    Nassau 11568
    Usa
    AmericanInvestor124206730001
    ROTHSCHILD, Nathaniel Philip Victor James, Hon
    8 St Luke's Place
    New York
    Ny 10014
    United States
    Diretor
    8 St Luke's Place
    New York
    Ny 10014
    United States
    UsaBritishInvestor87240400001
    SALVA, Vincent Manuel
    56 The Street
    Liddington
    SN4 0HD Swindon
    Wiltshire
    Diretor
    56 The Street
    Liddington
    SN4 0HD Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishNetwork Operations Director66363810001
    SECCOMBE, Jonathan Paul
    1240 Lansdowne Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AB Gloucester
    Gloucestershire
    Diretor
    1240 Lansdowne Court
    Gloucester Business Park
    GL3 4AB Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishFinance Director80993480001
    SUNNER, Mark
    1 Cheltenham Road
    GL7 2HS Cirencester
    Gloucestershire
    Diretor
    1 Cheltenham Road
    GL7 2HS Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritishTechnical Director51019070001
    SWEET, Rory James Wordsworth
    Ladyswood House
    Ladyswood
    SN16 0LA Malmesbury
    Wiltshire
    Diretor
    Ladyswood House
    Ladyswood
    SN16 0LA Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishChairman51528480003
    WHITE, Benjamin Vincent St John
    Beaufort House
    West Approach Drive
    GL52 3AD Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    Beaufort House
    West Approach Drive
    GL52 3AD Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChairman/Ceo141601010001
    WHITE, Christopher John Vincent
    Court House
    Stretton On Fosse
    GL56 9SD Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Diretor
    Court House
    Stretton On Fosse
    GL56 9SD Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    United KingdomBritishNon-Executive Director242099030001
    WHITE, Jocelyn Christopher
    106 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    Diretor
    106 Evesham Road
    GL52 2AL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishMarketing Director51018000003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Diretor nomeado
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Quem são as pessoas com controle significativo de MESSAGELABS GROUP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Nortonlifelock Uk Holding Limited
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    06/04/2016
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    MESSAGELABS GROUP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Criado em 14/11/2008
    Entregue em 19/11/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb re messagelabs with sort code 30-00-09 and numbered 00339622 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 19/11/2008Registro de uma garantia (395)
    • 23/12/2013Satisfação de uma garantia (MR04)
    A deed of security over agreements
    Criado em 25/06/2007
    Entregue em 09/07/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The relevant agreements and all their related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 09/07/2007Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Criado em 03/10/2006
    Entregue em 12/10/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 12/10/2006Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Criado em 20/04/2005
    Entregue em 21/04/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    By way of first fixed charge the deposit and all such rights to the repayment thereof as the company may have under the terms upon which the deposit was made. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 21/04/2005Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 22/03/2005
    Entregue em 30/03/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 30/03/2005Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated
    Criado em 06/07/2004
    Entregue em 17/07/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 17/07/2004Registro de uma garantia (395)
    • 05/12/2008Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0