KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED

KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Declaração anual
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaKILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03920625
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    • (7415) /

    Onde fica KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Updown Court
    Chertsey Road
    GU20 6HY Windlesham
    Surrey
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    TEESMARTIN PROPERTIES LIMITED28/04/200028/04/2000
    CITYFRONT LIMITED07/02/200007/02/2000

    Quais são as últimas contas de KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/04/2009

    Qual é o status da última declaração anual para KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Declaração anual
    Última declaração anual

    Quais são as últimas submissões para KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    7 páginas4.71

    Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 14/06/2014

    9 páginas4.68

    Nomeação de um liquidador voluntário

    1 páginas600

    Nomeação de um liquidador voluntário

    600

    Restauração por ordem judicial

    3 páginasAC92

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    10 páginas4.71

    Resolução de insolvência

    Resolution insolvency:ordinary resolution ;- "books, records.etc"
    2 páginasLIQ MISC RES

    Resolução de insolvência

    Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie"
    2 páginasLIQ MISC RES

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação

    LRESSP

    Nomeação de um liquidador voluntário

    600

    Declaração de solvência

    3 páginas4.70

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Declaração anual preparada até 07/02/2011 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital21/02/2011

    Estado do capital em 21/02/2011

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Exercício contabilístico anterior prorrogado de 30/04/2010 para 31/10/2010

    1 páginasAA01

    Resoluções

    Resolutions
    29 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução dos estatutos

    RES01

    Término da nomeação de Gordon Bennet como diretor

    2 páginasTM01

    Endereço do domicílio registado alterado de * the 6Th Floor Coin House 2 Gees Court London W1U 1JA* em 18/03/2010

    2 páginasAD01

    Declaração anual preparada até 07/02/2010 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01

    Contas anuais preparadas até 30/04/2009

    12 páginasAA

    Nomeação de Gordon Iain Bennet como diretor

    3 páginasAP01

    Nomeação de Susan Elizabeth Groat como diretor

    3 páginasAP01

    Quem são os diretores de KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    Diretor
    Castle Street
    EH2 5AH Edinburgh
    7
    Midlothian
    ScotlandBritish88980540001
    BROOK, Susan Margaret
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    Secretário
    16 Bradley Lane
    Rufforth
    YO23 3QJ York
    North Yorkshire
    British72328070001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    24 Littlefield Close
    Nether Poppleton
    YO2 6HX York
    North Yorkshire
    Secretário
    24 Littlefield Close
    Nether Poppleton
    YO2 6HX York
    North Yorkshire
    British56953000001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Secretário
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    British83466350002
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Secretário
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secretário
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    ZAJAC, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Secretário
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320002
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secretário
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretário nomeado
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Diretor
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    United KingdomBritish60009740002
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Diretor
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Diretor
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    Diretor
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish141515870001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Diretor
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Diretor
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    British97869190001
    OLIVER, Paul Francis
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    Diretor
    6 Burnaby Crescent
    Chiswick
    W4 3LH London
    British14735150001
    PECK, David Howard
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    Diretor
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    British48939900005
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Diretor
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Diretor
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Diretor nomeado
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Floating charge
    Criado em 20/04/2007
    Entregue em 02/05/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 02/05/2007Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Security agreement
    Criado em 07/10/2003
    Entregue em 17/10/2003
    Pendente
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee (whether on its own account or on behalf of any of the security beneficiaries) or to the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all the present and future right title and interest of that chargor in and to all the charged securities which are at any time owned by that chargor or in which that chargor from time to time has an interest together with all related rights from time to time occurring to those charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Bradford & Bingley PLC (Security Trustee)
    Transações
    • 17/10/2003Registro de uma garantia (395)
    Debenture
    Criado em 06/03/2002
    Entregue em 09/03/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/03/2002Registro de uma garantia (395)
    • 17/02/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    KILMARTIN PROPERTIES (NO.2) LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    15/06/2011Início da liquidação
    17/07/2015Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Laura May Waters
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Profissional
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Timothy Gerard Walsh
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Profissional
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0