RHM LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRHM LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03946774
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RHM LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica RHM LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RHM LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RHM PLC01/07/200501/07/2005
    305TH SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED14/03/200014/03/2000

    Quais são as últimas contas de RHM LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até03/04/2021

    Quais são as últimas submissões para RHM LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01

    Todo o bem ou empresa já não faz parte da garantia 039467740009

    1 páginasMR05

    Declaração de confirmação apresentada em 01/07/2022 com atualizações

    4 páginasCS01

    Estado do capital em 13/12/2021

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 03/04/2021

    22 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 01/07/2021 com atualizações

    4 páginasCS01

    Estado do capital em 23/03/2021

    • Capital: GBP 348,795.425
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancel share prem a/c 22/03/2021
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 22/03/2021

    • Capital: GBP 1,801,141,827.425
    4 páginasSH01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    resolution

    Resolução de capitalização ou de emissão de ações bónus

    Capitalise £515397000 and £1285396032 22/03/2021
    RES14

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado do capital em 26/01/2021

    • Capital: GBP 348,795.425
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado do capital após uma atribuição de ações em 11/01/2021

    • Capital: GBP 883,900,000
    4 páginasSH01

    Resoluções

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    resolution

    Resolução de capitalização ou de emissão de ações bónus

    Capitalise £883.9M 11/01/2021
    RES14

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Contas anuais preparadas até 28/03/2020

    19 páginasAA

    Quem são os diretores de RHM LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish194179970001
    ROSE, Simon Alan
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish105238100003
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Secretário
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Secretário
    HP9
    British145901880001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretário
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretário
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Secretário
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    British42065200002
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretário
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretário nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Diretor
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BAULK, Michael Robert Gordon
    Cawsand Place
    West Drive Wentworth
    GU25 4NE Virginia Water
    Surrey
    Diretor
    Cawsand Place
    West Drive Wentworth
    GU25 4NE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish13148210001
    BUCHAN, Brian John
    Manor Farmhouse
    Fyfield
    OX13 5LR Abingdon
    Oxfordshire
    Diretor
    Manor Farmhouse
    Fyfield
    OX13 5LR Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish75146390001
    DU PLESSIS, Jan Petrus
    7 Westfield Road
    HP9 1EG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    7 Westfield Road
    HP9 1EG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British31540220001
    HANSON, Richard Peter
    Low Wood House
    24 Blackhills
    KT10 9JW Esher
    Surrey
    Diretor
    Low Wood House
    24 Blackhills
    KT10 9JW Esher
    Surrey
    British42472200003
    HEPBURN, Jim
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ScotlandScottish162125080001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136797430001
    LEAHY, John Joseph Mary
    Woodsgift House
    Nuffield Lane
    RG10 6QQ Wallington
    Oxfordshire
    Diretor
    Woodsgift House
    Nuffield Lane
    RG10 6QQ Wallington
    Oxfordshire
    Irish98660310001
    MATTHEWS, Roger John
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    Diretor
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    United KingdomBritish133414230001
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrish168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Diretor
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MCPHERSON, Kasey
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomNew Zealander246893430001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Diretor
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    SCHOEWEL, Erhard Hans Josef
    22 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    Diretor
    22 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    German71409150003
    SCHOFIELD, Robert John
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    Diretor
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish80018490002
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Diretor
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish42065200002
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish147725160001
    TERRY, Kenneth John
    Pear Tree House No 1 Parkgate
    SE3 9XE London
    Diretor
    Pear Tree House No 1 Parkgate
    SE3 9XE London
    British59725690001
    THOMAS, Paul
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    British29218800002
    VAZANOVA, Janka
    Flat C
    31 Palace Court
    W2 4LP London
    Diretor
    Flat C
    31 Palace Court
    W2 4LP London
    Slovakian71194520001
    WILKINSON, Paul Nigel
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    Diretor
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    United KingdomBritish90533810001

    Quem são as pessoas com controle significativo de RHM LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St. Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06/04/2016
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St. Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Não
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroCompanies House
    Número de registro04426994
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    RHM LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 14/04/2014
    Entregue em 17/04/2014
    Pendente
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Agent and Trustee for the Senior Secured Creditors)
    Transações
    • 17/04/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 18/08/2022Todo o imóvel ou empresa não mais faz parte da garantia (MR05)
    An english law security agreement
    Criado em 30/03/2012
    Entregue em 04/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all rights in respect of key brand ipr including any interest by way of licence in any such key brand ipr by way of a first floating charge all its assets see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 04/04/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    A security agreement
    Criado em 27/03/2009
    Entregue em 03/04/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    First floating charge against all assets not at any time otherwise effectively mortgage charged or assigned under the deed see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 03/04/2009Registro de uma garantia (395)
    • 02/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 12/01/2009
    Entregue em 22/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 22/01/2009Registro de uma garantia (395)
    • 06/04/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Group debenture
    Criado em 28/02/2008
    Entregue em 10/03/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Floating charge over the undertaking and all property and assets see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transações
    • 10/03/2008Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A supplemental deed to a group debenture
    Criado em 13/04/2007
    Entregue em 24/04/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Floating charge its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and assets situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/04/2007Registro de uma garantia (395)
    • 02/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture
    Criado em 26/07/2004
    Entregue em 06/08/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transações
    • 06/08/2004Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    First supplemental debenture to a debenture dated 21ST july 2000 between rhm group one limited, the chargors (as defined) and morgan guaranty trust company of new york as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Criado em 28/02/2001
    Entregue em 28/02/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents (or any of them) together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection preservationor enforcement of its respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents on a full indemnity basis (all terms as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transações
    • 28/02/2001Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture between the company,rhm group two limited,rhm group three limited,rhm group four limited and rhm group a limited as chargors
    Criado em 21/07/2000
    Entregue em 27/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents (or any of them) together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents on a full indemnity basis (all terms as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York as Agent and Trusteefor Itself and Each of the Lenders (The "Security Agent")
    Transações
    • 27/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0