RHM FOODBRANDS+ LIMITED

RHM FOODBRANDS+ LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaRHM FOODBRANDS+ LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 03977324
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?

    • Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas

    Onde fica RHM FOODBRANDS+ LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    RHM GROUP A LIMITED14/07/200014/07/2000
    2114TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED20/04/200020/04/2000

    Quais são as últimas contas de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2013

    Quais são as últimas submissões para RHM FOODBRANDS+ LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Nomeação de Mr Simon Nicholas Wilbraham como diretor em 05/04/2015

    2 páginasAP01
    X45YM5TE

    Término da nomeação de Jim Hepburn como diretor em 05/04/2015

    1 páginasTM01
    X45YM5NE

    O processo de exclusão voluntária foi suspenso.

    1 páginasSOAS(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Nomeação de Mr Duncan Neil Leggett como diretor em 12/01/2015

    2 páginasAP01
    X3Z8ACRF

    Término da nomeação de Emmett Mcevoy como diretor em 12/01/2015

    1 páginasTM01
    X3Z8ACKQ

    Satisfação total da garantia 039773240008

    4 páginasMR04
    A3Z38LY9

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01
    A3NBI0FT

    Estado do capital em 12/12/2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19
    A3MDPG7D

    legacy

    1 páginasSH20
    S3MCJZ69

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    S3MCJZ61

    Resoluções

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração anual preparada até 01/07/2014 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital08/07/2014

    Estado do capital em 08/07/2014

    • Capital: GBP 58,276
    SH01
    X3BOBB5M

    Contas anuais modificadas preparadas até 31/12/2013

    14 páginasAAMD
    A3APHON6

    Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2014 para 31/03/2015

    1 páginasAA01
    X3A8D1S8

    Contas anuais preparadas até 31/12/2013

    14 páginasAA
    A37L1OYJ

    Satisfação total da garantia 6

    4 páginasMR04
    A370NZEO

    Satisfação total da garantia 3

    4 páginasMR04
    A370NZEW

    Satisfação total da garantia 7

    4 páginasMR04
    A370NZF4

    Registo da garantia 039773240008

    188 páginasMR01
    A360X243

    Declaração anual preparada até 01/07/2013 com lista completa de acionistas

    4 páginasAR01
    X2BOXGER

    Detalhes do diretor alterados para Mr Jim Hepburn em 25/06/2013

    2 páginasCH01
    X2B9AV0G

    Quem são os diretores de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secretário
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector194179970001
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secretário
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secretário
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Secretário
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    British42065200002
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secretário
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretário
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secretário
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    BritishDirector37177620001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretário nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Diretor
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    BritishFinance Director Chartered Acc73003300001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Diretor
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinancial Director145901880001
    HANSON, Richard Peter
    Low Wood House
    24 Blackhills
    KT10 9JW Esher
    Surrey
    Diretor
    Low Wood House
    24 Blackhills
    KT10 9JW Esher
    Surrey
    BritishChief Operating Officer42472200003
    HEPBURN, Jim
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ScotlandScottishCommercial Finance Director162125080001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Diretor
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector Of Companies136797430001
    MCEVOY, Emmett
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishDirector168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Diretor
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    BritishChief Executive84644240002
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Diretor
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Counsel76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Diretor
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    BritishChartered Accountant114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Controller87359710001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Diretor
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector98350001
    SCHOFIELD, Robert John
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    Diretor
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    United KingdomBritishChief Executive Officer80018490002
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Diretor
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector42065200002
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Diretor
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishNone147725160001
    TERRY, Kenneth John
    Pear Tree House No 1 Parkgate
    SE3 9XE London
    Diretor
    Pear Tree House No 1 Parkgate
    SE3 9XE London
    BritishManaging Director59725690001
    THOMAS, Paul
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    Diretor
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFinance Director29218800002
    VAZANOVA, Janka
    Flat C
    31 Palace Court
    W2 4LP London
    Diretor
    Flat C
    31 Palace Court
    W2 4LP London
    SlovakianPrincipal71194520001
    WILKINSON, Paul Nigel
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    Diretor
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    United KingdomBritishCompany Director90533810001
    WISE, Suzanne Elizabeth
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Diretor
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector Of Companies136781050001
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Diretor
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector37177620001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Diretor nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001760001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Diretor nomeado
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001750001
    SPV MANAGEMENT LIMITED
    Tower 42 Level 11 International
    Financial Centre 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Diretor
    Tower 42 Level 11 International
    Financial Centre 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    24311810008

    RHM FOODBRANDS+ LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    A registered charge
    Criado em 14/04/2014
    Entregue em 17/04/2014
    Totalmente satisfeita
    Contém uma promessa negativa: Sim
    Contém uma garantia flutuante: Sim
    Contém uma garantia fixa: Sim
    Pessoas com direito
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Agent and Trustee for the Senior Secured Creditors)
    Transações
    • 17/04/2014Registro de uma garantia (MR01)
    • 14/01/2015Satisfação de uma garantia (MR04)
    An english law security agreement
    Criado em 30/03/2012
    Entregue em 04/04/2012
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    By way of first fixed charge all rights in respect of key brand ipr including any interest by way of licence in any such key brand ipr by way of a first floating charge all its assets see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 04/04/2012Registro de uma garantia (MG01)
    • 02/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    A security agreement
    Criado em 27/03/2009
    Entregue em 03/04/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    First floating charge against all assets not at any time otherwise effectively mortgage charged or assigned under the deed see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transações
    • 03/04/2009Registro de uma garantia (395)
    • 02/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Security agreement
    Criado em 12/01/2009
    Entregue em 22/01/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transações
    • 22/01/2009Registro de uma garantia (395)
    • 06/04/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Group debenture
    Criado em 28/02/2008
    Entregue em 10/03/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Floating charge over the undertaking and all property and assets see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transações
    • 10/03/2008Registro de uma garantia (395)
    • 18/02/2009Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    A supplemental deed to a group debenture
    Criado em 13/04/2007
    Entregue em 24/04/2007
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Floating charge its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and assets situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transações
    • 24/04/2007Registro de uma garantia (395)
    • 02/05/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined)
    Criado em 28/02/2001
    Entregue em 20/03/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis.
    Breve descrição
    All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Chase Manhattan Bank (As Borrower Security Trustee)
    Transações
    • 20/03/2001Registro de uma garantia (395)
    • 28/07/2003Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 03/09/2005Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade de um encargo flutuante foi liberada (403b)
    • 21/09/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited,rhm group two limited,rhm group three limited,rhm group four limited and the company as chargors
    Criado em 21/07/2000
    Entregue em 27/07/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents (or any of them) together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents on a full indemnity basis (all terms as defined)
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York as Agent and Trustee for Itselfand Each of the Lenders (The "Security Agent")
    Transações
    • 27/07/2000Registro de uma garantia (395)
    • 21/07/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0