RHM FOODBRANDS+ LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | RHM FOODBRANDS+ LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 03977324 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica RHM FOODBRANDS+ LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
RHM GROUP A LIMITED | 14/07/2000 | 14/07/2000 |
2114TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 20/04/2000 | 20/04/2000 |
Quais são as últimas contas de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/12/2013 |
Quais são as últimas submissões para RHM FOODBRANDS+ LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Nomeação de Mr Simon Nicholas Wilbraham como diretor em 05/04/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Jim Hepburn como diretor em 05/04/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Nomeação de Mr Duncan Neil Leggett como diretor em 12/01/2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Emmett Mcevoy como diretor em 12/01/2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 039773240008 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado do capital em 12/12/2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Declaração anual preparada até 01/07/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais modificadas preparadas até 31/12/2013 | 14 páginas | AAMD | ||||||||||
Exercício contabilístico atual prorrogado de 31/12/2014 para 31/03/2015 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Satisfação total da garantia 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Registo da garantia 039773240008 | 188 páginas | MR01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/07/2013 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Jim Hepburn em 25/06/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Quem são os diretores de RHM FOODBRANDS+ LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretário | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
LEGGETT, Duncan Neil | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 194179970001 | ||||
MCDONALD, Andrew John | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | General Counsel & Company Secretary | 164670820001 | ||||
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 125719290002 | ||||
HARTREY, Patrick Mark | Secretário | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
HINES, Christine Anne | Secretário | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
SCHURCH, Michael John | Secretário | 1 Aldersey Road GU1 2ER Guildford Surrey | British | 42065200002 | ||||||
WATERS, Paul Christopher | Secretário | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretário | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
WOODMORE, Michael Brian | Secretário | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | Director | 37177620001 | |||||
SISEC LIMITED | Secretário nomeado | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||
ALLNER, Andrew James | Diretor | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | Finance Director Chartered Acc | 73003300001 | |||||
CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Diretor | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 98818450001 | ||||
CROSSLEY, Nigel | Diretor | Tempsford 34 Grove Road HP9 1PE Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Financial Director | 145901880001 | ||||
HANSON, Richard Peter | Diretor | Low Wood House 24 Blackhills KT10 9JW Esher Surrey | British | Chief Operating Officer | 42472200003 | |||||
HEPBURN, Jim | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | Scotland | Scottish | Commercial Finance Director | 162125080001 | ||||
LEACH, Paul Alan | Diretor | Station Road Bletchingdon OX5 3DE Kidlington 8 Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director Of Companies | 136797430001 | ||||
MCEVOY, Emmett | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | Irish | Director | 168590540001 | ||||
MCMAHON, Ian Reid | Diretor | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | Chief Executive | 84644240002 | |||||
MURPHY, Thomas Jerome Peter | Diretor | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | General Counsel | 76945730001 | |||||
PANTER, Alan James, Mr. | Diretor | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | Chartered Accountant | 114414690002 | |||||
PEELER, Andrew Michael | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Controller | 87359710001 | ||||
RUDDICK, Ian William | Diretor | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | Director | 98350001 | ||||
SCHOFIELD, Robert John | Diretor | 32 Thames Edge Court Clarence Street TW18 4SP Staines Middlesex | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 80018490002 | ||||
SCHURCH, Michael John | Diretor | 1 Aldersey Road GU1 2ER Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director | 42065200002 | ||||
SMITH, Antony David | Diretor | Centrium Business Park Griffiths Ways AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | United Kingdom | British | None | 147725160001 | ||||
TERRY, Kenneth John | Diretor | Pear Tree House No 1 Parkgate SE3 9XE London | British | Managing Director | 59725690001 | |||||
THOMAS, Paul | Diretor | Gladwyn House 5 Victoria Crescent Sherwood NG5 4DA Nottingham Nottinghamshire | British | Finance Director | 29218800002 | |||||
VAZANOVA, Janka | Diretor | Flat C 31 Palace Court W2 4LP London | Slovakian | Principal | 71194520001 | |||||
WILKINSON, Paul Nigel | Diretor | 20 Roehampton Gate Roehampton SW15 5JS London | United Kingdom | British | Company Director | 90533810001 | ||||
WISE, Suzanne Elizabeth | Diretor | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Director Of Companies | 136781050001 | ||||
WOODMORE, Michael Brian | Diretor | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | England | British | Director | 37177620001 | ||||
LOVITING LIMITED | Diretor nomeado | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001760001 | |||||||
SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001750001 | |||||||
SPV MANAGEMENT LIMITED | Diretor | Tower 42 Level 11 International Financial Centre 25 Old Broad Street EC2N 1HQ London | 24311810008 |
RHM FOODBRANDS+ LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Criado em 14/04/2014 Entregue em 17/04/2014 | Totalmente satisfeita | ||
Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
An english law security agreement | Criado em 30/03/2012 Entregue em 04/04/2012 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição By way of first fixed charge all rights in respect of key brand ipr including any interest by way of licence in any such key brand ipr by way of a first floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A security agreement | Criado em 27/03/2009 Entregue em 03/04/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição First floating charge against all assets not at any time otherwise effectively mortgage charged or assigned under the deed see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Security agreement | Criado em 12/01/2009 Entregue em 22/01/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição First floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Group debenture | Criado em 28/02/2008 Entregue em 10/03/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Floating charge over the undertaking and all property and assets see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
A supplemental deed to a group debenture | Criado em 13/04/2007 Entregue em 24/04/2007 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Floating charge its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and assets situated in scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined) | Criado em 28/02/2001 Entregue em 20/03/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis. | |
Breve descrição All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Debenture between rhm group one limited,rhm group two limited,rhm group three limited,rhm group four limited and the company as chargors | Criado em 21/07/2000 Entregue em 27/07/2000 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents (or any of them) together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents on a full indemnity basis (all terms as defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0