2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED

2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresa2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04057272
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    • Produção de produtos de carne e carne de aves (10130) / Indústrias transformadoras

    Onde fica 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Trinity Park House Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    West Yorkshire
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    BROOMCO (2316) LIMITED22/08/200022/08/2000

    Quais são as últimas contas de 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/07/2022

    Quais são as últimas submissões para 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaração de confirmação apresentada em 12/12/2023 com atualizações

    4 páginasCS01
    XCIPK9EO

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    1 páginasDS01
    XCFEP59V

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/07/2022

    8 páginasAA
    AC8A8EA8

    Término da nomeação de Ronald Klaas Otto Kers como diretor em 26/05/2023

    1 páginasTM01
    XC568L9F

    Nomeação de Mrs Joanne Caroline Kershaw Simmonds como diretor em 22/05/2023

    2 páginasAP01
    XC41WVWB

    Memorando e estatutos

    14 páginasMA
    YC0V2LJV

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    incorporation

    Resolução de adoção dos estatutos

    RES01

    Estado do capital em 19/04/2023

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19
    AC1QU3AO

    legacy

    1 páginasSH20
    AC1QU36R

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    AC1QU3AG

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Término da nomeação de Baljinder Kaur Boparan como diretor em 24/01/2023

    1 páginasTM01
    XBW1SDMX

    Término da nomeação de Ranjit Singh Boparan como diretor em 24/01/2023

    1 páginasTM01
    XBW1SDOH

    Declaração de confirmação apresentada em 12/12/2022 com atualizações

    4 páginasCS01
    XBIPX3F6

    Declaração de confirmação apresentada em 22/08/2022 sem atualizações

    3 páginasCS01
    XBBKC1H4

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/07/2021

    8 páginasAA
    AB82O03U

    Declaração de confirmação apresentada em 22/08/2021 sem atualizações

    3 páginasCS01
    XABLGHC3

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 01/08/2020

    8 páginasAA
    AA6PH020

    Detalhes do diretor alterados para Mr Craig Ashley Tomkinson em 29/03/2021

    2 páginasCH01
    XA1DG027

    Declaração de confirmação apresentada em 22/08/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X9D2CWUB

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 27/07/2019

    8 páginasAA
    A916E040

    Declaração de confirmação apresentada em 22/08/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01
    X8CQ401D

    Contas modificadas para uma sociedade inativa preparadas até 28/07/2018

    8 páginasAAMD
    A89XCC36

    Quem são os diretores de 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SIMMONDS, Joanne Caroline Kershaw
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector309294840001
    TOMKINSON, Craig Ashley
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishGroup Cfo199432160002
    BOPARAN, Ranjit Singh
    Shivalika
    Roman Lane
    B74 3AF Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secretário
    Shivalika
    Roman Lane
    B74 3AF Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector161730930001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Secretário
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    British24487000002
    DUKE, Shirley Ann
    Cedar House, Ridge View
    Harmston
    LN5 9GH Lincoln
    Lincolnshire
    Secretário
    Cedar House, Ridge View
    Harmston
    LN5 9GH Lincoln
    Lincolnshire
    British77975660004
    GLANFIELD, Martin James
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    Secretário
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant206032560001
    MCMELLON, Christopher John
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    Secretário
    12 Grovehill Crescent
    TR11 3HR Falmouth
    Cornwall
    BritishCompany Secretary43249730003
    NOBLE, Barry
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    Secretário
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector64538550001
    NOBLE, Barry
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    Secretário
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    BritishAccountant64538550001
    SILK, Jon Stanley
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    Secretário
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector95721520002
    SILK, Jon Stanley
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    Secretário
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant95721520002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretário nomeado
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BOPARAN, Baljinder Kaur
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector58257960003
    BOPARAN, Ranjit Singh
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector202931710001
    CHALLLIS, Keith
    The Grove
    Ditchingham
    NR35 2QY Bungay
    Suffolk
    Diretor
    The Grove
    Ditchingham
    NR35 2QY Bungay
    Suffolk
    BritishDirector76504880001
    DAVIES, Gareth Wyn
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant109674760001
    FARROW, Raymond
    Low Grange Farm
    Gallamore Lane
    LN8 3US Middle Rasen
    Lincolnshire
    Diretor
    Low Grange Farm
    Gallamore Lane
    LN8 3US Middle Rasen
    Lincolnshire
    BritishDirector77975550001
    FINCH, Graham William
    3 High Street
    Blisworth
    NN7 3BJ Northampton
    Northamptonshire
    Diretor
    3 High Street
    Blisworth
    NN7 3BJ Northampton
    Northamptonshire
    BritishGeneral Manager15950480001
    FLETCHER, Martyn Paul
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCoo235080230001
    GLANFIELD, Martin James
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    Diretor
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishChartered Accountant206032560001
    HENDERSON, Stephen
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant103853510001
    IRWIN, Henry James
    Reading Hall
    Denham Corner, Denham
    IP21 5DR Eye
    Suffolk
    Diretor
    Reading Hall
    Denham Corner, Denham
    IP21 5DR Eye
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector89067030001
    KERS, Ronald Klaas Otto, Mr.
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    EnglandDutchGroup Ceo170539300001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Cfo84487230001
    LILBURN, David
    Deborah Farm
    Westmoor Lane
    LN1 2JW Kettlethorpe
    Lincolnshire
    Diretor
    Deborah Farm
    Westmoor Lane
    LN1 2JW Kettlethorpe
    Lincolnshire
    BritishDirector73948140001
    NICOL, George
    Robinson Farm Bungalow
    Eakring Road Bilsthorpe
    NG22 8SX Newark
    Nottinghamshire
    Diretor
    Robinson Farm Bungalow
    Eakring Road Bilsthorpe
    NG22 8SX Newark
    Nottinghamshire
    BritishDirector33458170002
    NOBLE, Barry
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    Diretor
    Qynton House
    Winderton
    OX15 5JF Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant64538550001
    PARSONS, Richard James, Sales And Marketing Director
    River House
    Huntsham
    EX16 7NQ Tiverton
    Devon
    Diretor
    River House
    Huntsham
    EX16 7NQ Tiverton
    Devon
    BritishSales Director15792820002
    PIKE, Richard Neil
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    Diretor
    Trinity Business Park
    Fox Way
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishGroup Cfo236794290001
    ROSSER, Andrew James
    Old Bridge Farm
    Plymtree
    EX15 2LR Cullompton
    Devon
    Diretor
    Old Bridge Farm
    Plymtree
    EX15 2LR Cullompton
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director45284250001
    SILK, Jon Stanley
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    Diretor
    Dial Lane
    West Bromwich
    B70 0EB Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishChartered Accounatnt95721520002
    SILK, Jon Stanley
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    Diretor
    Hatherton House
    The Old Rectory
    WS15 3NL Admaston
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Accountant95721520002
    WEEDS, Graham Raymond
    Bridge Fen
    29 Low Road
    IP20 0HJ Wortwell Harleston
    Norfolk
    Diretor
    Bridge Fen
    29 Low Road
    IP20 0HJ Wortwell Harleston
    Norfolk
    BritishDirector74254490001
    WOODRUFF, Chris David Capps
    Penlea
    Darrow Green
    IP20 0BA Denton Harleston
    Norfolk
    Diretor
    Penlea
    Darrow Green
    IP20 0BA Denton Harleston
    Norfolk
    BritishDirector74254240001
    WRIXON, Trevor Anthony
    18 Church Hill
    Pinhoe
    EX4 9EX Exeter
    Devon
    Diretor
    18 Church Hill
    Pinhoe
    EX4 9EX Exeter
    Devon
    BritishDirector34231870002

    Quem são as pessoas com controle significativo de 2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Boparan Holdings Limited
    Trinity Business Park
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    England
    06/04/2016
    Trinity Business Park
    WF2 8EE Wakefield
    Trinity Park House
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroUk Companies House
    Número de registro03558065
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

    2 SISTERS PREMIER DIVISION LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 31/10/2005
    Entregue em 09/11/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a plot 1 dial lane west bromwich t/n WM846607. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 09/11/2005Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 03/11/2000
    Entregue em 14/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The f/h property k/a land and buildings at george road flixton bungay suffolk t/n SK93345. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 03/11/2000
    Entregue em 14/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/H land and buildings on the north east side of mark lane east markham and land lying to the south of low street east markham t/nos.NT319508 and NT327202. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 03/11/2000
    Entregue em 14/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All the f/h and l/h property k/a land and buildings on the north side of ram boulevard foxhills industrial estate, land and buildings on the west side of park farm road, land at park farm road, scunthorpe and aeration basins and other plant at the british steel biological effluent treatment plant park farm road scunthorpe t/nos.HS158635, HS174411 and HS180528. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 03/11/2000
    Entregue em 14/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All the f/h property k/a blundells road tiverton part t/no.DN299470. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 03/11/2000
    Entregue em 14/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Legal charge
    Criado em 03/11/2000
    Entregue em 14/11/2000
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    F/Hold property known as units 11A and 11B boundary rd,brackley; t/no nn 110166. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 14/11/2000Registro de uma garantia (395)
    • 15/03/2011Declaração de que parte ou a totalidade da propriedade onerada foi liberada (MG04)
    • 06/05/2011Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0