SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Insolvência
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaSERVICED OFFICES UK GP LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04063878
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaSim
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    • Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

    Onde fica SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    CORPORATE CENTRES GP LIMITED15/03/200115/03/2001
    STONEMARTIN (GP) LIMITED29/08/200029/08/2000

    Quais são as últimas contas de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até30/06/2018

    Quais são as últimas submissões para SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Boletim final dissolvido após liquidação

    1 páginasGAZ2

    Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios

    8 páginasLIQ13

    Declaração de confirmação apresentada em 01/10/2020 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Endereço do domicílio registado alterado de St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom para 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS em 27/12/2019

    1 páginasAD01

    Declaração de solvência

    4 páginasLIQ01

    Nomeação de um liquidador voluntário

    2 páginas600

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    liquidation

    Resolução especial para a liquidação em 10/12/2019

    LRESSP

    Término da nomeação de Kirsty Ann-Marie Wilman como diretor em 02/12/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mrs Karina Jane Bye como diretor em 02/12/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Nicholas Tebbutt como diretor em 02/12/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr David Rowley Rose como diretor em 02/12/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Julian Miles Cobourne como diretor em 02/12/2019

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Jennifer Anne Lisbey como diretor em 02/12/2019

    1 páginasTM01

    Nomeação de Ms Jennifer Anne Lisbey como diretor em 15/10/2019

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Matthew James Torode como diretor em 23/08/2019

    1 páginasTM01

    Declaração de confirmação apresentada em 01/10/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2018

    2 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 18/09/2018 com atualizações

    6 páginasCS01

    Nomeação de Mr Matthew Torode como diretor em 13/03/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de David Leonard Grose como diretor em 13/03/2018

    1 páginasTM01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2017

    2 páginasAA

    Detalhes do diretor alterados para Mr Nicholas Tebbutt em 19/03/2018

    2 páginasCH01

    Declaração de confirmação apresentada em 18/09/2017 com atualizações

    6 páginasCS01

    Nomeação de Mr. Nicholas Tebbutt como diretor em 28/07/2017

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Catherine Jane Mccall como diretor em 28/07/2017

    1 páginasTM01

    Quem são os diretores de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Secretário
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Tipo de identificaçãoSociedade limitada do Reino Unido
    Número de registro2084205
    1278390004
    BYE, Karina Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Diretor
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish239237640001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Diretor
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish89567200001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Secretário
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    British62939740001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretário nomeado
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHCROFT, Jonathan Edwin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Diretor
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish131434980001
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Diretor
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Diretor
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Diretor
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritish101932350001
    COBOURNE, Julian Miles
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Diretor
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    EnglandBritish198725060001
    DAWSON, Robert George Maxwell
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    Diretor
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    EnglandBritish77316930001
    DRYSDALE, James Ferguson
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    Diretor
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    British61174240003
    ELLIS, Philip Frederick
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    Diretor
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish75296640001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Diretor
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritish32807790002
    GROSE, David Leonard
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    Diretor
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    United KingdomAustralian120479020001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Diretor
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Diretor
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish198871760001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Diretor
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish62939740001
    LINDSEY, Joel Mark Woodliffe
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Diretor
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomNew Zealand140768720001
    LINEHAM, Timothy Mark Vaughan
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    Diretor
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish66505360002
    LISBEY, Jennifer Anne
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    Diretor
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    United KingdomBritish259968930001
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Diretor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritish73817060002
    MCCALL, Catherine Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Diretor
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish204318160001
    MCKEOWN, Audrey
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Diretor
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomIrish124787300002
    SHAH, Nikunj Nalin
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    Diretor
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    United KingdomBritish131325870001
    TEBBUTT, Nicholas, Mr.
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    Diretor
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    United KingdomBritish228645590002
    THODAY, Corin Leonard
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Diretor
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish138095630001
    TORODE, Matthew James
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    Diretor
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish196412900002
    TURNER, Alex James
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    Diretor
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    United KingdomBritish110252440002
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    Diretor
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    EnglandBritish155163600002
    WISE, David Andrew John
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    Diretor
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    United KingdomBritish74016310001
    WOMACK, Ian Bryan
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    Diretor
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    United KingdomBritish33902000002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Diretor nomeado
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quem são as pessoas com controle significativo de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Norwich Union (Shareholder Gp) Limited
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    06/04/2016
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    Não
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridade legalCompanies Act 2006
    Local de registroRegister Of Companies
    Número de registro03783750
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25%, mas não mais de 50% dos direitos de voto na empresa.
    • A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.

    SERVICED OFFICES UK GP LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Legal charge
    Criado em 08/12/2008
    Entregue em 16/12/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company as general partner on behalf of the partnership and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    L/H property k/a temple circus temple way bristol t/no. BL97044 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 16/12/2008Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 21/07/2008
    Entregue em 22/07/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property k/a peter house st peter's square manchester t/no GM597635 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 21/07/2008
    Entregue em 22/07/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property k/a 1 victoria square birmingham t/no WM172095 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 21/07/2008
    Entregue em 22/07/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property k/a 45-48 (inclusive) swallow street birmingham T.no WM367351 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • Bank of Sscotland PLC
    Transações
    • 22/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 21/07/2008
    Entregue em 22/07/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The property k/a land on the south side of swallow street birmingham t/no WM368514 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 21/07/2008
    Entregue em 22/07/2008
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The propert k/a the golden eagle corner of hill street and swallow street birmingham t/no WM389526.
    Pessoas com direito
    • Bank of Scotland PLC
    Transações
    • 22/07/2008Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Legal charge
    Criado em 11/06/2004
    Entregue em 19/06/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    The l/h property known as forbury square reading. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 19/06/2004Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Criado em 25/01/2002
    Entregue em 29/01/2002
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    All undertaking property and assets of the partnership whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transações
    • 29/01/2002Registro de uma garantia (395)
    • 05/07/2014Satisfação de uma garantia (MR04)

    SERVICED OFFICES UK GP LIMITED possui casos de insolvência?

    Número do processoDatasTipoProfissionaisOutro
    1
    DataTipo
    10/12/2019Início da liquidação
    18/02/2021Data de dissolução
    Liquidação voluntária de sócios
    NomeFunçãoEndereçoNomeado emCessado em
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Profissional
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0