ELEPHANT WEST LIMITED

  • Visão geral
  • Resumo
  • Objetivo
  • Endereço
  • Nomes anteriores
  • Contas
  • Submissões
  • Diretores
  • Pessoas com controle significativo
  • Encargos
  • Fonte de Dados
  • Visão geral

    Nome da empresaELEPHANT WEST LIMITED
    Estado da empresaDissolvida
    Forma jurídicaSociedade privada limitada
    Número da empresa 04089358
    JurisdiçãoInglaterra/País de Gales
    Data de criação
    Data de cessação

    Resumo

    Possui PSCs super segurosNão
    Possui encargosSim
    Possui histórico de insolvênciaNão
    O escritório registrado está em disputaNão

    Qual é o objetivo de ELEPHANT WEST LIMITED?

    • outras atividades de fabricação n.e.c. (32990) / Indústrias transformadoras

    Onde fica ELEPHANT WEST LIMITED?

    Endereço do escritório registrado
    Studio Building
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Endereço do escritório registrado não entregávelNão

    Quais eram os nomes anteriores de ELEPHANT WEST LIMITED?

    Nomes anteriores da empresa
    Nome da empresaDeAté
    LETRASET LIMITED19/06/200119/06/2001
    CREATIVE OPPORTUNITIES LIMITED31/01/200131/01/2001
    LETRASET LIMITED09/10/200009/10/2000

    Quais são as últimas contas de ELEPHANT WEST LIMITED?

    Últimas contas
    Últimas contas elaboradas até31/12/2017

    Quais são as últimas submissões para ELEPHANT WEST LIMITED?

    Submissões
    DataDescriçãoDocumentoTipo

    Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária

    1 páginasGAZ2(A)

    Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária

    1 páginasGAZ1(A)

    Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial

    3 páginasDS01

    Declaração de confirmação apresentada em 04/04/2019 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas anuais modificadas preparadas até 31/12/2017

    19 páginasAAMD

    Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2018 com atualizações

    4 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2017

    14 páginasAA

    Nomeação de Mr Adrianus Van Schie como diretor em 06/02/2018

    2 páginasAP01

    Término da nomeação de Mark Barratt como diretor em 16/08/2018

    1 páginasTM01

    Nomeação de Mr Jonathan Paul William Spight como diretor em 06/02/2018

    2 páginasAP01

    Resoluções

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    change-of-name

    Resolução de alteração da denominação social

    RES15

    Aviso de alteração do nome"

    2 páginasCONNOT

    Estado do capital em 23/01/2018

    • Capital: GBP 1,000
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluções

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Resoluções
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital

    Resoluções

    Cancellation of share premium 18/12/2017
    RES13
    capital

    Resolução de redução do capital social emitido

    RES06

    Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2017 sem atualizações

    3 páginasCS01

    Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016

    11 páginasAA

    Declaração de confirmação apresentada em 09/10/2016 com atualizações

    9 páginasCS01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2015

    15 páginasAA

    Declaração anual preparada até 09/10/2015 com lista completa de acionistas

    7 páginasAR01
    Submissões associadas
    CategoriaDataDescriçãoTipo
    capital05/11/2015

    Estado do capital em 05/11/2015

    • Capital: GBP 483,973.43
    SH01

    Término da nomeação de Thomas Carl Hanz Brautigam como diretor em 02/10/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Thomas Carl Hanz Brautigam como diretor em 02/10/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen Michael Adams como diretor em 31/10/2015

    1 páginasTM01

    Término da nomeação de Stephen Michael Adams como diretor em 31/10/2015

    1 páginasTM01

    Contas anuais preparadas até 31/12/2014

    16 páginasAA

    Quem são os diretores de ELEPHANT WEST LIMITED?

    Diretores
    NomeNomeado emRenunciou emFunçãoEndereçoIdentificação da empresaPaís de residênciaNacionalidadeData de nascimentoOcupaçãoNúmero
    SPIGHT, Jonathan Paul William
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    Diretor
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    EnglandBritish216794410001
    VAN SCHIE, Adrianus Hendrikus Maria
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    Diretor
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    EnglandDutch202024180002
    BALDOCK, Simon Paul
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Secretário
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    British117307130001
    GOTHARD, Nigel
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    Secretário
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    British77437250001
    PEPALL, Lewis John
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    Secretário
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    175170150001
    BRACHERS LIMITED
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    Secretário
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    80957680001
    ADAMS, Stephen Michael
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Diretor
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    EnglandBritish175188190001
    BALDOCK, Simon Paul
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Diretor
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish117307130001
    BARRATT, Mark
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    Diretor
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    EnglandBritish201080080001
    BOWEN, Anthony David
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Diretor
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    United KingdomBritish150068230001
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Diretor
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritish99584240001
    BRAUTIGAM, Thomas Carl Hanz
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Diretor
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    United KingdomSwedish134706290001
    GIBBS, Roy Martin
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Diretor
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish37073140002
    GOTHARD, Nigel
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    Diretor
    3 Chaucer Mews
    CT2 9BF Upper Harbledown
    Kent
    EnglandBritish77437250001
    GREGORY, Jonathan David Leigh
    Millbeck 31 The Hordens
    Barns Green
    RH13 7PH Horsham
    West Sussex
    Diretor
    Millbeck 31 The Hordens
    Barns Green
    RH13 7PH Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish44708850001
    HOAREAU, Guillaume
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Diretor
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandFrench137444890001
    HODGES, Simon Christopher
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Diretor
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish149484790001
    JOHNSTON, Mark Frederick
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    Diretor
    Kingsnorth Industrial Estate
    Wotton Road
    TN23 6FL Ashford
    Kent
    EnglandBritish86246750001
    PEPALL, Lewis John
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    Diretor
    Goldthorn Road
    DY11 7JN Kidderminster
    Colart
    England
    United KingdomBritish161095610001
    ROPER, Gordon Edward Lawrence
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Diretor
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Great BritainBritish120319980002
    TRAVERS, Michael Brian
    La-Vista
    19 Temeraire Heights
    CT20 3TL Folkestone
    Kent
    Diretor
    La-Vista
    19 Temeraire Heights
    CT20 3TL Folkestone
    Kent
    United KingdomBritish72345270002
    WRAIGHT, Justin
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    Diretor
    21 Evesham Street
    W11 4AJ London
    Studio Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish169908430001

    Quem são as pessoas com controle significativo de ELEPHANT WEST LIMITED?

    Pessoas com controle significativo
    NomeNotificado emEndereçoCessado
    Colart International Holdings Ltd
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    21
    England
    09/10/2016
    Evesham Street
    W11 4AJ London
    21
    England
    Não
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridade legalCompanies Act
    Natureza do controle
    • A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.

    ELEPHANT WEST LIMITED possui encargos?

    Encargos
    ClassificaçãoDatasEstadoDetalhes
    Guarantee & debenture
    Criado em 09/03/2009
    Entregue em 12/03/2009
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Pessoas com direito
    • Matrix Private Equity Partners LLP
    Transações
    • 12/03/2009Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Criado em 21/07/2006
    Entregue em 01/08/2006
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Porex LS1030 PWZ2 new production tool, porex LS1030 PWZ3 new production tool and dg mortimer & co LTD barrel tool new main cartridge barrel tools for details of further equipment charged please refer to form 395.
    Pessoas com direito
    • Lombard North Central PLC
    Transações
    • 01/08/2006Registro de uma garantia (395)
    • 26/05/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Criado em 14/11/2005
    Entregue em 19/11/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transações
    • 19/11/2005Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 12/10/2005
    Entregue em 15/10/2005
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • National Westminster Bank PLC
    Transações
    • 15/10/2005Registro de uma garantia (395)
    • 09/06/2012Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (MG02)
    Debenture
    Criado em 06/01/2004
    Entregue em 08/01/2004
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Pessoas com direito
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transações
    • 08/01/2004Registro de uma garantia (395)
    • 24/01/2006Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Mortgage of assurance policies
    Criado em 19/06/2001
    Entregue em 27/06/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    With full title guarantee assigns to the bank all the policy or policies of assurance described in the the schedule to the mortgage being the policy over the life of roy martin gibbs (policy number 0091202366) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus and the policy over the life of michael brian travers (policy number 0091201889) assuring the sum of £250,000 exclusive of bonus.
    Pessoas com direito
    • Fortis Bank Sa-Nv UK
    Transações
    • 27/06/2001Registro de uma garantia (395)
    • 21/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)
    Debenture
    Criado em 19/06/2001
    Entregue em 27/06/2001
    Totalmente satisfeita
    Montante garantido
    All monies due or to become due from the company formerly known as creative opportunities limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descrição
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Pessoas com direito
    • Fortis Bank Sa-Nv UK Branch
    Transações
    • 27/06/2001Registro de uma garantia (395)
    • 15/12/2005Declaração de satisfação de um encargo na totalidade ou em parte (403a)

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0