BLSSP (PHC 6) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | BLSSP (PHC 6) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 04104070 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de BLSSP (PHC 6) LIMITED?
- desenvolvimento de projetos de construção (41100) / Construção
Onde fica BLSSP (PHC 6) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de BLSSP (PHC 6) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2019 |
Quais são as últimas submissões para BLSSP (PHC 6) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 03/11/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de James Watson como diretor em 23/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Hursh Shah como diretor em 23/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de James Andrew Honeyman como diretor em 23/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Bruce Richardson como diretor em 23/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Dean Clegg como diretor em 23/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Martyn Stephen Burke como diretor em 23/10/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2019 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Bruce Richardson como diretor em 14/06/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de David Clifford Wheeler como diretor em 14/06/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado do capital em 20/06/2019
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfação total da garantia 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Término da nomeação de Sarah Nelson como diretor em 14/01/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr David Clifford Wheeler como diretor em 14/01/2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 3 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 2 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Quem são os diretores de BLSSP (PHC 6) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretário | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| COWEN, Geraint Jamie | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 141040000003 | |||||||||
| PINKSTONE, James Michael | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 241498640001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Secretário | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretário | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretário | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ADAM, Shenol | Diretor | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | 2068480001 | ||||||||||
| ATKINSON, William Stephen | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 174566650001 | |||||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Diretor | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | 175617500001 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Diretor | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BELL-BROWN, Philip | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 119073370001 | |||||||||
| BIRCH, John Matthew | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 191027500001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Diretor | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Diretor | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| BURKE, Martyn Stephen | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 152531940004 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Diretor | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLEGG, Dean | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 189632520001 | |||||||||
| COHEN, Carolina Alfred | Diretor | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 248093020001 | |||||||||
| FLEMING, Richard Alexander | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 125990210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Diretor | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FRANCIS, Luke Thomas | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 223122340001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Diretor | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HONEYMAN, James Andrew | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 201179510001 | |||||||||
| HOORN, Antony John Van Der | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 170891040001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Diretor | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Diretor | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 58257940003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Diretor | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Diretor | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Stephen Howard | Diretor | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 185276290002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de BLSSP (PHC 6) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blssp Property Holdings Limited | 06/04/2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
| |||||||
BLSSP (PHC 6) LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 03/07/2015 Entregue em 10/07/2015 | Totalmente satisfeita | ||
Breve descrição M& s land parcel. Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Supplemental deed | Criado em 05/04/2013 Entregue em 23/04/2013 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição F/H land being on the east side of high road the north side of glebelands avenue and the south west side of george lane south woodford t/no EGL60105 and f/h land being on the south side of george lane south woodford t/no EGL370456 fixed charge all rental income any guarantee of rental income,its rights under any security or deposit agreement or arrangement see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Borrower deed of charge | Criado em 28/02/2006 Adquirido em 05/04/2013 Entregue em 16/04/2013 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição All rights title and interest in the existing nominee property assets see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Borrower deed of charge | Criado em 28/02/2006 Entregue em 09/03/2006 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar") | Criado em 20/06/2001 Entregue em 06/07/2001 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined) | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0